GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED

GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04133359
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED?

    • (4521) /
    • (7011) /

    Dove si trova GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 21 lug 2014

    1 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 11 lug 2014

    2 pagine3.6

    Bilancio redatto al 31 mag 2013

    13 pagineAA

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 11 gen 2014

    2 pagine3.6

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mag 2014 al 30 nov 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mag 2012

    13 pagineAA

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 11 lug 2013

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 11 gen 2013

    2 pagine3.6

    Cessazione della carica di Peter Anthony Owen come amministratore in data 30 ott 2012

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom in data 15 ago 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mag 2011

    12 pagineAA

    legacy

    2 pagineLQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Bothy Albury Park Albury Guildford Surrey GU5 9BH England in data 15 giu 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mag 2010

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard Godkin come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Richard Godkin come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Brian Joseph Siegel come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di David Alan Katz come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2011

    Stato del capitale al 18 gen 2011

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Chancery House Leas Road Guildford Surrey GU1 4QW in data 02 lug 2010

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KATZ, David Alan
    Second Street Pike
    Suite 150
    Southampton
    283
    Pa 18966
    Usa
    Amministratore
    Second Street Pike
    Suite 150
    Southampton
    283
    Pa 18966
    Usa
    UsaAmericanDirector157433930001
    SIEGEL, Brian Joseph
    Second Street Pike
    Suite 150
    Southampton
    283
    Pa 18966
    Usa
    Amministratore
    Second Street Pike
    Suite 150
    Southampton
    283
    Pa 18966
    Usa
    UsaAmericanAttorney157432740001
    GODKIN, Richard Michael Aston
    Orchard Cottage
    96 The Mount
    GU2 4JB Guildford
    Surrey
    Segretario
    Orchard Cottage
    96 The Mount
    GU2 4JB Guildford
    Surrey
    BritishChartered Accountant64756270002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FRY, Christopher Raymond
    42 Mayfield Gardens
    KT12 5PP Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    42 Mayfield Gardens
    KT12 5PP Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritishDirector75905910002
    GODKIN, Richard Michael Aston
    Orchard Cottage
    96 The Mount
    GU2 4JB Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Orchard Cottage
    96 The Mount
    GU2 4JB Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant64756270002
    GORDENO, Fiona Francis Marie
    95 Charrington Way
    Broadbridge Heath
    RH12 3TL Horsham
    Amministratore
    95 Charrington Way
    Broadbridge Heath
    RH12 3TL Horsham
    BritishDirector75906170002
    MOORE, Stephen Charles
    27 Church Road
    SL4 2PH Old Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    27 Church Road
    SL4 2PH Old Windsor
    Berkshire
    EnglandBritishDirector104536830001
    NEATE, Christopher Philip
    9 Jubilee Lane
    GU10 4SZ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    9 Jubilee Lane
    GU10 4SZ Farnham
    Surrey
    EnglandBritishDirector75920760001
    OSBORNE, Stephen Brian
    1 Lewisham Way
    Owlsmoor
    GU47 0YJ Sandhurst
    Berkshire
    Amministratore
    1 Lewisham Way
    Owlsmoor
    GU47 0YJ Sandhurst
    Berkshire
    BritishDirector62932120001
    OWEN, Peter Anthony
    17 Grays Lane
    KT21 1BZ Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    17 Grays Lane
    KT21 1BZ Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector90652000001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 22 ago 2008
    Consegnato il 27 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Site rear of newtree furlong, mount close, guildford road, fetcham by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 15 ago 2007
    Consegnato il 16 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17-19A crescent road worthing west susse. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 114 gen 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 115 ago 2014Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 1
    Legal and equitable charge
    Creato il 30 mag 2006
    Consegnato il 08 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    West lodge warren lane oxshott surrey.
    Persone aventi diritto
    • The Crown Estate Commissioners
    Transazioni
    • 08 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 2006
    Consegnato il 23 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at west lodge, warren lane, oxsott. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 2006
    Consegnato il 11 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 69 meadrow, godalming. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 10 mar 2006
    Consegnato il 25 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 24 feb 2003
    Consegnato il 06 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a bowling green paddock putney heath SW15.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 13 feb 2003
    Consegnato il 24 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 19 mar 2001
    Consegnato il 24 mar 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Kh Associates LP
    Transazioni
    • 24 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 mar 2001
    Consegnato il 20 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a the cottage fairoak lane oxshott fixed charge over the goodwill of the company at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2001
    Consegnato il 08 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a field house manor way knott park oxshott t/n SY181658 by way of fixed charge the goodwill.by way of floating charge all plant machinery equipment furniture and other chattel assets.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 2001
    Consegnato il 08 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings on the south side of portsmouth road putney SW15 t/no;-433785 fixed charge goodwill of any business on or fron the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 gen 2001
    Consegnato il 08 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit & Mercantile PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GRENVILLE HOMES EASTERN LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Rosalind Jane Goode
    Gva Grimley Limited 10 Stratton Street
    W1J 8JR London
    Ricevitore/gestore
    Gva Grimley Limited 10 Stratton Street
    W1J 8JR London
    Nathan John Pask
    20 Stratton Street
    W1J 8JR London
    Ricevitore/gestore
    20 Stratton Street
    W1J 8JR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0