FINCO CS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFINCO CS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04134744
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FINCO CS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova FINCO CS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o LUCID ISSUER SERVICES LIMITED
    Tankerton Works
    12 Argyle Walk
    WC1H 8HA London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FINCO CS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DAMOVO CORPORATE SERVICES LIMITED15 mar 200215 mar 2002
    DAMOVO UK FINANCE I LIMITED06 set 200106 set 2001
    ENTERPRISE SOLUTIONS UK FINANCE I LIMITED29 mar 200129 mar 2001
    DAMSONDALE LIMITED03 gen 200103 gen 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di FINCO CS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per FINCO CS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2017

    44 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 gen 2016

    53 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mar 2016

    Stato del capitale al 29 mar 2016

    • Capitale: GBP 686,973
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2015

    57 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road London N1 3QP a C/O Lucid Issuer Services Limited Tankerton Works 12 Argyle Walk London WC1H 8HA in data 25 nov 2015

    1 pagineAD01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed damovo corporate services LIMITED\certificate issued on 02/04/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name02 apr 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 mar 2015

    RES15

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mar 2015

    Stato del capitale al 04 mar 2015

    • Capitale: GBP 686,973
    SH01

    Nomina di Mr Salim Sarwar Alam come segretario in data 26 feb 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Robert Graham Hynd come segretario in data 26 feb 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 gen 2014

    28 pagineAA

    Cessazione della carica di Salim Alam come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 feb 2014

    Stato del capitale al 28 feb 2014

    • Capitale: GBP 686,973
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2013

    29 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 gen 2012

    30 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 gen 2011

    28 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    7 pagineMEM/ARTS

    Chi sono gli amministratori di FINCO CS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALAM, Salim Sarwar
    Speldhurst Road
    W4 1BZ London
    44
    England
    Segretario
    Speldhurst Road
    W4 1BZ London
    44
    England
    195535740001
    MCCUSKER, Helen Bernadette
    Calabar Court
    Cathkin
    G73 5RL Glasgow
    9
    Scotland
    Amministratore
    Calabar Court
    Cathkin
    G73 5RL Glasgow
    9
    Scotland
    ScotlandBritish158086570001
    BOOTH, Rachel Sarah
    91 Harrison Road
    EH11 1LS Edinburgh
    Segretario
    91 Harrison Road
    EH11 1LS Edinburgh
    British43448790001
    HYND, Robert Graham
    Dunglass Avenue
    G14 9ED Glasgow
    27
    Scotland
    Segretario
    Dunglass Avenue
    G14 9ED Glasgow
    27
    Scotland
    British31887890001
    MCMELLON, Christopher John
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    Segretario
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    British43249730003
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    MASONS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    30 Aylesbury Street
    EC1R 0ER London
    Segretario
    30 Aylesbury Street
    EC1R 0ER London
    32643220001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    ALAM, Salim Sarwar
    44 Speldhurst Road
    W4 1BZ London
    Amministratore
    44 Speldhurst Road
    W4 1BZ London
    EnglandBritish122506270001
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Amministratore
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    British79800380001
    BOOTH, Rachel Sarah
    123 St Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Amministratore
    123 St Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    British79930170001
    BOYLE, Joseph Anthony
    12 Huntly Avenue
    G46 6LW Glasgow
    Amministratore
    12 Huntly Avenue
    G46 6LW Glasgow
    ScotlandBritish96947560001
    COLLINS, Michael David
    2 Alexandra House
    Queenshill Close London Road
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    2 Alexandra House
    Queenshill Close London Road
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish122053370001
    CONTRERAS, Robert Leonard
    9 Thorp Arch Park
    LS23 7AP Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Thorp Arch Park
    LS23 7AP Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish93499270001
    FITZGERALD, David James
    55 Ridgway Place
    SW19 4SP London
    Amministratore
    55 Ridgway Place
    SW19 4SP London
    EnglandIrish141363290001
    FITZGERALD, David James
    Beechwood House
    RH12 4SD Faygate
    West Sussex
    Amministratore
    Beechwood House
    RH12 4SD Faygate
    West Sussex
    Irish75198210003
    FLYNN, Pearse
    Greystones
    Houston Road
    PA13 4NY Kilmacolm
    Renfrewshire
    Amministratore
    Greystones
    Houston Road
    PA13 4NY Kilmacolm
    Renfrewshire
    Irish75749140001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MCCUSKER, Helen Bernadette
    2-42 Glasgow Road
    FG71 7BA Uddingston
    Glasgow
    Glasgow
    Amministratore
    2-42 Glasgow Road
    FG71 7BA Uddingston
    Glasgow
    Glasgow
    British126380710001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SAMUEL, John
    Little Quebb Farm
    Eardisley
    HR3 6LP Hereford
    Amministratore
    Little Quebb Farm
    Eardisley
    HR3 6LP Hereford
    British92480690001
    SLOAN, Michael Robert William, Mr.
    Kingsford Avenue
    G44 3EU Glasgow
    43
    Amministratore
    Kingsford Avenue
    G44 3EU Glasgow
    43
    United KingdomBritish138578730001
    STATHOPOULOS, Nikolaos
    Flat B
    6 Redcliffe Place
    SW10 9DD London
    Amministratore
    Flat B
    6 Redcliffe Place
    SW10 9DD London
    Greek75198270001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FINCO CS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Finco Ii Sarl
    Boulevard Royal
    L-2449
    25a
    Luxembourg
    06 apr 2016
    Boulevard Royal
    L-2449
    25a
    Luxembourg
    No
    Forma giuridicaLuxembourg Holding Company
    Paese di registrazioneLuxembourg
    Autorità legaleLuxembourg Law On Commerial Companies 1915
    Luogo di registrazioneLuxembourg Company Registry
    Numero di registrazioneB 81 250
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    FINCO CS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 gen 2007
    Consegnato il 25 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Equity Trust Services (UK) Limited
    Transazioni
    • 25 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An equitable mortgage
    Creato il 22 apr 2005
    Consegnato il 29 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the issuer and each guarantor to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge the mortgaged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 29 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Equitable mortgage of shares
    Creato il 18 mar 2005
    Consegnato il 23 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgaged assets being the mortgaged shares and the related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London (As Trustee for and on Behalf of the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 23 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 30 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any obligor to the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Apax Europe Iv G.P. Co. Limited as Trustee for and on Behalf of the Lenders (The Security Agent)
    Transazioni
    • 30 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 mag 2004
    Consegnato il 20 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC
    Transazioni
    • 20 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of security of intercompany loans
    Creato il 04 mag 2001
    Consegnato il 19 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally and whether as principal or surety or in any capacity whatsoever) of the assignor or any obligor to the secured creditors (or any of them) under or in relation to any one or more of the senior finance documents and/or the mezzanine finance documents all terms as defined
    Brevi particolari
    All the right title and interest present and future of the assignor in,to and under the intergroup loans together with all claims rights and remedies of the assignor and sums due to it in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 19 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable mortgage of shares
    Creato il 04 mag 2001
    Consegnato il 19 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally and whether as principal or surety or in any capacity whatsoever) of the company or any obligor to the secured creditors (or any of them) under or in relation to any one or more of the senior finance documents and/or the mezzanine finance documents all terms as defined
    Brevi particolari
    The company charges with full title guarantee the mortgaged assets being the mortgaged shares and the related assets and all other shares held in the future by it and/or any nominee on its behalf to the security agent by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 19 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0