BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION

BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited'
    Numero di società 04135915
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION?

    • Altre attività sportive (93199) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 16 Intech House 34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Herts
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE BRITISH SHOW HACK, COB AND RIDING HORSE ASSOCIATION13 lug 200113 lug 2001
    THE SHOW HACK, COB & RIDING HORSE ASSOCIATION04 gen 200104 gen 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al04 gen 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma18 gen 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al04 gen 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Ms Michelle Rebecca Underwood come amministratore in data 01 dic 2025

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Debra Harrod come amministratore in data 01 dic 2025

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Darren Price come amministratore in data 01 dic 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian William Darcy come amministratore in data 01 dic 2025

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Somers come amministratore in data 01 dic 2025

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Darcy come segretario in data 01 dic 2025

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Magnus Francis Benedict Nicholson come amministratore in data 06 ott 2025

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2024

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Sarah Elizabet Chapman come amministratore in data 29 apr 2025

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian William Darcy il 04 gen 2025

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 gen 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ms Sarah Elizabet Chapman come amministratore in data 17 nov 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Susan Phillips come amministratore in data 17 nov 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stuart Hollings come amministratore in data 17 nov 2024

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel George Hollings il 04 gen 2025

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Susan Phillips il 04 gen 2025

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarah Jane Lewis Carey il 04 gen 2025

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Sarah Jane Lewis Carey il 04 gen 2025

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel George Hollings il 04 gen 2025

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian William Darcy il 04 gen 2025

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    18 pagineMA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2023

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Richard Telford come amministratore in data 12 feb 2024

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ATKIN-BOWDLER, Katherine
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    WalesWelsh292993600001
    HARROD, Debra
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    EnglandBritish314583370001
    HOLLINGS, Nigel George
    Showley Road
    Clayton Le Dale
    BB1 9DP Blackburn
    Blue Slate Barn
    England
    Amministratore
    Showley Road
    Clayton Le Dale
    BB1 9DP Blackburn
    Blue Slate Barn
    England
    EnglandBritish109858490002
    LEWIS CAREY, Sarah Jane
    Frampton Rise
    Wirksworth Road
    DE56 4AQ Belper
    Frampton Rise
    Derbyshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Frampton Rise
    Wirksworth Road
    DE56 4AQ Belper
    Frampton Rise
    Derbyshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish101937990002
    NEAME, Camilla
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United KingdomBritish318572990001
    NICHOLSON, Magnus Francis Benedict
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    EnglandBritish177291910001
    PRICE, Darren
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    EnglandBritish245185760001
    REYNOLDS, Simon
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United KingdomBritish293001320001
    SMEETH, Ian
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United KingdomBritish292993430001
    TELFORD, Richard
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    ScotlandBritish319230240001
    UNDERWOOD, Michelle Rebecca
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    EnglandBritish340806500001
    DARCY, Ian
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Segretario
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    292998680001
    HALL, Jane
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Segretario
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    284251980001
    JONES, Patricia Jean
    Sandpits Bungalow
    Old Malvern Road, Powick
    WR2 4RX Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    Sandpits Bungalow
    Old Malvern Road, Powick
    WR2 4RX Worcester
    Worcestershire
    British27460360002
    POMROY, Camilla, Treasurer
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Segretario
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    280750030001
    PYBUS, Joanne
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Segretario
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    280456830001
    SAVILL, Lucy Caroline
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Segretario
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    203299470002
    SMYTH, Adrianne Fairfax
    Todds End
    Todds Green
    SG1 2JE Stevenage
    Hertfordshire
    Segretario
    Todds End
    Todds Green
    SG1 2JE Stevenage
    Hertfordshire
    British63552090001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Segretario nominato
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    WARREN, Peter John
    Home Farm
    Gatcombe
    PO30 3EJ Newport
    Isle Of Wight
    Segretario
    Home Farm
    Gatcombe
    PO30 3EJ Newport
    Isle Of Wight
    British48578850002
    WILKERSON, Charles Ellis
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Segretario
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    174724530001
    YOUNG, Edward William
    Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Whitelands Farm
    Derbyshire
    England
    Segretario
    Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Whitelands Farm
    Derbyshire
    England
    184478700001
    CHAPMAN, Sarah Elizabet
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    United Kingdom
    WalesBritish56455020001
    CLUTTON, Jo
    Back Lane
    Waldron
    TN21 0NE Heathfield
    White Farm
    East Sussex
    Amministratore
    Back Lane
    Waldron
    TN21 0NE Heathfield
    White Farm
    East Sussex
    United KingdomBritish135105730001
    CURTIS, David Maurice
    Horseshoe Farm
    Weston
    SG4 7AG Hitchin
    Herts
    Amministratore
    Horseshoe Farm
    Weston
    SG4 7AG Hitchin
    Herts
    United KingdomBritish12243990001
    DARCY, Ian William
    Church Farm
    Westerdale
    YO21 2DT Whitby
    Church Farm
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Farm
    Westerdale
    YO21 2DT Whitby
    Church Farm
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish3904400002
    GILBEY, Walter Anthony
    Ballacallin Mooar Crosby
    IM4 2HD Marown
    Isle Of Man
    Amministratore
    Ballacallin Mooar Crosby
    IM4 2HD Marown
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish51498260001
    HALL, Jane
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    EnglandBritish265766570001
    HARGREAVES, Rosalind Anne
    Lower Starbank Farm
    Dolphinholme
    LA2 9AP Lancaster
    Lancashire
    Amministratore
    Lower Starbank Farm
    Dolphinholme
    LA2 9AP Lancaster
    Lancashire
    British81005250001
    HEATH, Danielle
    Love Lane
    Betchton
    CW11 2TS Sandbach
    The Barn Lodge Townsend Farm
    England
    Amministratore
    Love Lane
    Betchton
    CW11 2TS Sandbach
    The Barn Lodge Townsend Farm
    England
    EnglandBritish252199380001
    HOLLINGS, Stuart
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    Amministratore
    34-35 The Cam Centre
    Wilbury Way
    SG4 0TW Hitchin
    Suite 16 Intech House
    Herts
    EnglandBritish305871850001
    INGLE, David Edward
    Old Gorse Way
    Mawsley
    NN14 1GJ Kettering
    22
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Old Gorse Way
    Mawsley
    NN14 1GJ Kettering
    22
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish147598470001
    JENKINS, Joanne
    Hornets Farm
    Padbury Road Thornborough
    MK18 2EB Buckingham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hornets Farm
    Padbury Road Thornborough
    MK18 2EB Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish93538430001
    KEEN, John
    Alderbourne Farm
    SL0 0N0 Iver Heath
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Alderbourne Farm
    SL0 0N0 Iver Heath
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80996430001
    KILLINGBECK, Lucy Jane
    Park Farm House
    GL11 6AT Stancombe
    Gloucestershire
    Amministratore
    Park Farm House
    GL11 6AT Stancombe
    Gloucestershire
    United KingdomBritish102121750001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per BRITISH SHOW HORSE ASSOCIATION?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    04 gen 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0