CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED

CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04139681
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED?

    • (7011) /
    • (7012) /

    Dove si trova CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Clock House
    87 Paines Lane
    HA5 3BZ Pinner
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LAWGRA (NO.739) LIMITED11 gen 200111 gen 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 nov 2010

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Albemarle House 1 Albemarle Street London W1 3HF in data 18 nov 2010

    2 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 16 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2010

    Stato del capitale al 22 gen 2010

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Marie O'reilly-Neenan come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    8 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    legacy

    1 pagine652C

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMYTH, Pamela June
    53 East Craigs Wynd
    EH12 8HJ Edinburgh
    Segretario
    53 East Craigs Wynd
    EH12 8HJ Edinburgh
    British65057960002
    BORLAND, Donald William
    408 Ferry Road
    EH5 2AD Edinburgh
    Amministratore
    408 Ferry Road
    EH5 2AD Edinburgh
    United KingdomBritish66010670002
    HEWETT, Frederic Mark
    16 The Drive
    TN9 2LP Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    16 The Drive
    TN9 2LP Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish52840680001
    MARSH, John Charles
    115 Upper Grosvenor Road
    TN1 2EA Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    115 Upper Grosvenor Road
    TN1 2EA Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish85346010001
    MILLER, Philip Hartley
    20 Gardiner Road
    Blackhall
    EH4 3RR Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    20 Gardiner Road
    Blackhall
    EH4 3RR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish28512070005
    MILLOY, David Thomas
    1 Thorn Avenue
    Thorntonhall
    G74 5AT Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    1 Thorn Avenue
    Thorntonhall
    G74 5AT Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish76474600001
    WISE, Richard John
    6 The Leas
    Longdean Park
    HP3 8BP Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 The Leas
    Longdean Park
    HP3 8BP Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59140110002
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Segretario nominato
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    FROST, Simon
    32 Sidney Road
    KT12 2LZ Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    32 Sidney Road
    KT12 2LZ Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritish16522420002
    HAMPSON, Lester Paul
    21 Brassey Hill
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    Amministratore
    21 Brassey Hill
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    British97665250001
    HARRIS, Nicholas John
    Evenlode,248 Station Road
    B93 0ES Knowle
    West Midlands
    Amministratore
    Evenlode,248 Station Road
    B93 0ES Knowle
    West Midlands
    United KingdomBritish74890900001
    JACKSON, Julie Mansfield
    31 Inverleith Gardens
    EH3 5PR Edinburgh
    Amministratore
    31 Inverleith Gardens
    EH3 5PR Edinburgh
    United KingdomBritish94193070001
    LAKER, John Frederick
    57 Greenways
    KT10 0QH Hinchley Woods
    Surrey
    Amministratore
    57 Greenways
    KT10 0QH Hinchley Woods
    Surrey
    United KingdomBritish54651510001
    O'REILLY-NEENAN, Marie Bernadette
    Ballymulcashel
    Kilmurry
    Sixmilebridge
    Ballymul House
    Ennis Co Clare
    Ireland
    Amministratore
    Ballymulcashel
    Kilmurry
    Sixmilebridge
    Ballymul House
    Ennis Co Clare
    Ireland
    Irish135305100001
    SUTHERLAND, Andrew
    87 Whitehouse Road
    EH4 6PB Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    87 Whitehouse Road
    EH4 6PB Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritish66368290001
    WOOD, Marlene
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish31152030002
    WHALE ROCK DIRECTORS LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Amministratore delegato nominato
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900019450001

    CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 09 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north east side of market street, maidstone, title number K242931, 10 and 10A market street, maidstone, title number K696827, 2-6 (even numbers) earl street together with 41 week street, maidstone, title number K622737 and 45 week street, maidstone, title number K43849. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 09 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment to the bank, and with full title guarantee, the deposit, as defined therein, as a continuing security for the discharge on demand of the depositor's liabilities subject to re-assignment on redemption.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Cash deposit security deed
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 09 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge to the bank, and with full title guarantee, the deposit, as defined therein, as a continuing security for the discharge on demand of the depositor's liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    CENTROS MILLER (MAIDSTONE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 ago 2011Data di scioglimento
    12 nov 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian David Holland
    Ian Holland & Co
    The Clock House
    HA5 3BZ 87 Paines Lane
    Pinner Middlesex
    Praticante
    Ian Holland & Co
    The Clock House
    HA5 3BZ 87 Paines Lane
    Pinner Middlesex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0