CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD

CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04140242
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    • Istruzione prescolare (85100) / Istruzione

    Dove si trova CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAYNES PARK NURSERY LIMITED12 gen 200112 gen 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Mary Ann Tocio come amministratore in data 01 giu 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2015

    Stato del capitale al 22 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 feb 2014

    Stato del capitale al 06 feb 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Stephen Kramer come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Nomina di Stephen Dreier come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di David Lissy come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mary Ann Tocio come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Elizabeth Boland come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mary Tocio come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Lissy come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Dreier come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elizabeth Boland come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Kramer come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Stephen Kramer come segretario

    3 pagineAP03

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Nomina di Elizabeth Boland come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di David Lissy come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Segretario
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    171973360001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Amministratore
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Amministratore
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Amministratore
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican218331690001
    BROSNAN, Paul
    Croom House
    IRISH Croom
    Co Limerick
    Ireland
    Segretario
    Croom House
    IRISH Croom
    Co Limerick
    Ireland
    Irish102089360001
    DHANANI, Alnur Madatali
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    Segretario
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    British2462470003
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Segretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    Segretario
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Segretario
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    British169896160001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Segretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British134350220001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BETTUM, Ole
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    Amministratore
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    EnglandNorwegian50551730002
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Amministratore
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican70853820001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    CARNEY, Joseph Gerard
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    Amministratore
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    United KingdomIrish89273480001
    DHANANI, Alnur Madatali
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    Amministratore
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    United KingdomBritish2462470003
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Amministratore
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican170443250001
    HEMSLEY, Maarten Duncan
    265 Washington Street
    Duxbury
    Massachusetts 02332
    Usa
    Amministratore
    265 Washington Street
    Duxbury
    Massachusetts 02332
    Usa
    United StatesBritish69602210003
    HURRAN, Anthony Robert
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish184743670001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Amministratore
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican218331690001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish115340530001
    PACE, Martin
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    Amministratore
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    EnglandBritish74305820001
    TERNOFSKY, Friedrich Ludwig Rudolf
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    United KingdomAustrian11820520001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Amministratore
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    UsaUsa177507090001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Amministratore
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    UsaUsa177507090001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 dic 2004
    Consegnato il 06 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,the Security Trustee
    Transazioni
    • 06 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 04 dic 2002
    Consegnato il 06 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property 105 gaynes park road upminster essex t/n EX21073. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 dic 2002
    Consegnato il 06 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 dic 2001
    Consegnato il 08 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 105 gaynes park road upminster RM14 2HX and all rights relating to the schedule property together with the contracts the book debts the intellectual property the plant and machinery the shares and derivative assets the goodwill and uncalled capital. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Development Vct PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 apr 2001
    Consegnato il 03 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    105 gaynes park road upminster RM14 2HX.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Development Vct PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0