VINTAGE DRINKS LIMITED

VINTAGE DRINKS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVINTAGE DRINKS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04141132
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VINTAGE DRINKS LIMITED?

    • (5134) /

    Dove si trova VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLASSIC DRINKS LIMITED15 feb 200115 feb 2001
    BROOMCO (2451) LIMITED15 gen 200115 gen 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 giu 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    GAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 giu 2013

    15 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 giu 2012

    16 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Sovereign Distillery Wilson Road Huyton Business Park Liverpool Merseyside L36 6AD United Kingdom* in data 14 giu 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 26 giu 2010

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 gen 2011

    Stato del capitale al 17 gen 2011

    • Capitale: GBP 750,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Unit 14 Reginald Road Industrial Estate Brindley Road St Helens Merseyside WA9 4JB* in data 22 ott 2010

    1 pagineAD01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed classic drinks LIMITED\certificate issued on 18/10/10
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name18 ott 2010

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 ott 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    28 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Bilancio redatto al 27 giu 2009

    21 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Alfred Joseph Vaughan il 24 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Donald Smallman il 24 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon John Oldroyd il 24 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Luke Horsfall il 24 feb 2010

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di VINTAGE DRINKS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HORSFALL, Peter Luke
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    Segretario
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    British109453290001
    HALEWOOD, John Edward
    The Sovereign Distillery
    Wilson Road Huyton Business Park
    L36 6AD Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    The Sovereign Distillery
    Wilson Road Huyton Business Park
    L36 6AD Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish6757540009
    OLDROYD, Simon John
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    Amministratore
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    United KingdomBritish32198870002
    SMALLMAN, Andrew Donald
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    Amministratore
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    EnglandBritish55685640001
    VAUGHAN, Alfred Joseph
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    Amministratore
    Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    12-14
    Hampshire
    United KingdomBritish90987590002
    HORSFALL, Peter Luke
    31 Welman Way
    WA15 8WE Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    31 Welman Way
    WA15 8WE Altrincham
    Cheshire
    British109453290001
    OLDROYD, Simon John
    Spa Farmhouse
    Spa Lane Lathom
    L40 6JG Ormskirk
    Lancashire
    Segretario
    Spa Farmhouse
    Spa Lane Lathom
    L40 6JG Ormskirk
    Lancashire
    British32198870002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    WHARTON, Dale
    4 Kingsmede
    WN1 2NL Wigan
    Amministratore
    4 Kingsmede
    WN1 2NL Wigan
    EnglandBritish74558220003
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    VINTAGE DRINKS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture created without written instrument
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 20 feb 2009
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Halewood International Holdings PLC
    Transazioni
    • 20 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 26 may 2000 and
    Creato il 23 mag 2008
    Consegnato il 07 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 11 mag 2006
    Consegnato il 24 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement (ogsa) dated 26 may 2000 and
    Creato il 22 mar 2005
    Consegnato il 24 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture deed
    Creato il 16 set 2003
    Consegnato il 23 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture deed
    Creato il 19 feb 2001
    Consegnato il 28 feb 2001
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    VINTAGE DRINKS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 giu 2011Inizio della liquidazione
    15 ago 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Alan David Fallows
    Barnett House 53 Fountain Street
    M2 2AN Manchester
    Praticante
    Barnett House 53 Fountain Street
    M2 2AN Manchester
    Gordon John Johnston
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Praticante
    Hjs Recovery 12-14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Hampshire
    Stephen Powell
    12/14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton
    Praticante
    12/14 Carlton Place
    SO15 2EA Southampton

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0