ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04146543 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Sands Mill Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ELANTRIAL LIMITED | 24 gen 2001 | 24 gen 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 set 2018
| 8 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 set 2018
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 28 set 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Gregory Francis Kilmister come amministratore in data 20 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr John Raymond Crabtree come segretario in data 20 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Edward Mullen come segretario in data 20 lug 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Wood come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Matthew Masters come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Wood come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Mark Andrew Kenneth Wood il 03 ott 2013 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRABTREE, John Raymond | Segretario | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | 236088830001 | |||||||
| MASTERS, Matthew Graham | Amministratore | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | England | British | 183080130001 | |||||
| CLUBB, Adrian | Segretario | Roman Way Borrowash DE72 3LX Derby 18 Derbyshire | British | 130740700001 | ||||||
| EVAN-COOK, Paul | Segretario | Borderigg Benhall Mill Road TN2 5JH Tunbridge Wells Kent | British | 7658310001 | ||||||
| LEIGH, Richard Ian | Segretario | 170 Haverstock Hill NW3 2AT London | British | 47707160001 | ||||||
| MULLEN, Timothy Edward | Segretario | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | British | 168488100001 | ||||||
| SOWERBY, Richard Anthony | Segretario | 49a Carr Hill Road Upper Cumberworth HD8 8XN Huddersfield | British | 60728080002 | ||||||
| WOOD, Mark Andrew Kenneth | Segretario | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | British | 113494040001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| ATWOOD, Robert Charles | Amministratore | Breakstones Speldhurst Road Langton Green TN3 0JL Tunbridge Wells Kent | England | British | 14065630001 | |||||
| DEDMAN, Julie Elizabeth | Amministratore | Hopton Brow 102 Hopton Lane WF14 8JP Upper Hopton Mirfield | England | British | 141993660001 | |||||
| FLYNN, Theresa May | Amministratore | 44 Thornton Way Girton CB3 0NJ Cambridge | British | 29751450003 | ||||||
| GOMAR, Mark James | Amministratore | Grubbs Lane Hatfield AL9 6EF Hertfordshire Westfield House | United Kingdom | British | 133321960001 | |||||
| KILMISTER, Gregory Francis | Amministratore | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | Australia | Australian | 161659660001 | |||||
| LOUDEN, Nicholas William | Amministratore | Ashby Road DE15 0YZ Bretby Esg House Bretby Business Park Burton On Trent | Wales | British | 76293900002 | |||||
| MCBRIDE, Richard Anthony | Amministratore | 10 Buckingham Street WC2N 6DF London | Uk | British | 80081060003 | |||||
| MCDOUGALL, Neil | Amministratore | Strood Place Strood Lane RH12 3PF Warnham West Sussex | British | 74825350001 | ||||||
| SILVER, Mark Jonathan | Amministratore | 10 Buckingham Street WC2N 6DF London | British | British | 42369970005 | |||||
| SLEETH, Alexander, Mr | Amministratore | Brackenwood Mews Wynchwood Mews CW2 5GQ Weston 6 Cheshire | United Kingdom | Scottish | 154283090002 | |||||
| SOWERBY, Richard Anthony | Amministratore | 49a Carr Hill Road Upper Cumberworth HD8 8XN Huddersfield | England | British | 60728080002 | |||||
| TOZZI, Keith | Amministratore | 20 Black Friars Lane EC4V 6HD London | United Kingdom | British | 58029330001 | |||||
| TOZZI, Keith | Amministratore | 20 Black Friars Lane EC4V 6HD London | United Kingdom | British | 58029330001 | |||||
| WOOD, Mark Andrew Kenneth | Amministratore | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | England | British | 113494040001 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eclipse Acquisitions Limited | 06 apr 2016 | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Creato il 08 set 2010 Consegnato il 16 set 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating security document | Creato il 14 mag 2008 Consegnato il 23 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its present and future right title and interest in and to the assigned agreements, see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession to a debenture originally dated 6 october 2005 as amended and restated on 28 april 2006 | Creato il 11 ago 2006 Consegnato il 19 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0