CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04152031 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | One Park Lane LS3 1EP Leeds |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| COACTIVA ASPIREN LTD | 25 ott 2010 | 25 ott 2010 |
| SUNGARD PUBLIC SECTOR ASPIREN LIMITED | 02 gen 2008 | 02 gen 2008 |
| SUNGARD ASPIREN LIMITED | 03 set 2007 | 03 set 2007 |
| ASPIREN LIMITED | 27 mag 2003 | 27 mag 2003 |
| PERFORM FIRST LTD | 31 lug 2001 | 31 lug 2001 |
| THE PERFORMANCE PARTNERSHIP.COM LIMITED | 01 feb 2001 | 01 feb 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 25 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione di Coactiva Limited come persona con controllo significativo il 29 mag 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Notifica di Transunion International Uk Limited come persona con controllo significativo il 29 mag 2020 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Nomina di Mr William John Flynn come amministratore in data 11 mag 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 15 mag 2020
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Satrijit Saha il 01 mar 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Satrijit Saha come amministratore in data 25 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Colin James Rutter come amministratore in data 29 feb 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Colin James Rutter come segretario in data 29 feb 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 26 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Kenneth Campbell Munro come amministratore in data 01 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Jon Gordon come amministratore in data 08 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Mark Edward Horsey come amministratore in data 13 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Colin James Rutter come amministratore in data 13 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Colin James Rutter come segretario in data 13 feb 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Kenneth Campbell Munro come segretario in data 13 feb 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYNN, William John | Amministratore | Park Lane LS3 1EP Leeds One | United Kingdom | British | 269944900001 | |||||
| HORSEY, Mark Edward | Amministratore | Park Lane LS3 1EP Leeds One | United Kingdom | British | 196671230001 | |||||
| SAHA, Satrajit | Amministratore | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | Indian | 267916570002 | |||||
| KNIGHTON, Christopher | Segretario | 11 Ackmar Road Fulham SW6 4UP London | British | 74366030002 | ||||||
| KNIGHTON, Esther | Segretario | 14 Beechwood Road DD11 4HS Arbroath Angus | British | 74365870001 | ||||||
| MUNRO, Robert Kenneth Campbell | Segretario | Park Lane LS3 1EP Leeds One | 197751810001 | |||||||
| RICHARDS, Elizabeth Anne | Segretario | Park Lane LS3 1EP Leeds One | British | 185280220001 | ||||||
| RUTTER, Colin James | Segretario | Park Lane LS3 1EP Leeds One | 255307610001 | |||||||
| WALLIS, Howard | Segretario | Brindle Lodge New Road, Headcorn TN27 9SE Ashford Kent | British | 80930830001 | ||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Segretario nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
| ASHWORTH, Gary | Amministratore | 3 Chapel Heights Bolnore Road RH16 4AN Haywards Heath West Sussex | British | 101851590001 | ||||||
| BRAIN, Bruce | Amministratore | West Sevington Farmhouse Yatton Keynell SN15 4NB Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | 9395440004 | |||||
| BURGE, Alan | Amministratore | Home Farm Close BA14 6AH Steeple Ashton 5 Wiltshire | United Kingdom | British | 197259620001 | |||||
| CHAPMAN, Brian Roy | Amministratore | Spring Acre Lower Washwell Lane GL6 6XW Painswick Gloucestershire | United Kingdom | British | 32009220003 | |||||
| FIELDING, Raymond Albert George | Amministratore | Lombard Street EC3V 9LJ London 68 | United Kingdom | British | 154664990001 | |||||
| GIBSON, John Leonard | Amministratore | Poffley End Hailey OX29 9UW Nr Witney Winnings Farmhouse Oxfordshire | United Kingdom | British | 173207750001 | |||||
| GORDON, Michael Jon | Amministratore | Park Lane LS3 1EP Leeds One | United Kingdom | British | 194337270002 | |||||
| KING, Evan Wayne | Amministratore | 24 Isaacson Road CB5 0AF Burwell Cambridgeshire | British | 106540190001 | ||||||
| KNIGHTON, Christopher | Amministratore | 11 Ackmar Road Fulham SW6 4UP London | England | British | 74366030002 | |||||
| MCANDREW, John Francis | Amministratore | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | British | 102419830002 | |||||
| MUNRO, Robert Kenneth Campbell | Amministratore | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | British | 137091090001 | |||||
| RICHARDS, Elizabeth Anne | Amministratore | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | British | 61958280002 | |||||
| RICHARDS, Elizabeth Anne | Amministratore | Cavendish Avenue HG2 8HY Harrogate 23 North Yorkshire England | England | British | 61958280002 | |||||
| RUANE, Michael Joseph | Amministratore | 11 Wembley Drive 08054 Mount Laurel New Jersey Usa | Usa | United States | 46331880001 | |||||
| RUTTER, Colin James | Amministratore | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | British | 123440320001 | |||||
| SANTOS, Gilbert Omar, Mr. | Amministratore | 7731 Flemingwood Ct. Sanford Florida 32771 Usa | Usa | American | 122432060001 | |||||
| SILBEY, Victoria Elizabeth | Amministratore | 15 Fox Ridge Drive 19355 Malvern Pennsylvania Usa | United States Of America | American | 110055430002 | |||||
| WATSON, Nigel | Amministratore | 13 Gordon Road E11 2RA London | England | British | 87589920001 | |||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Amministratore delegato nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transunion International Uk Limited | 29 mag 2020 | Park Lane LS3 1EP Leeds 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Coactiva Limited | 06 apr 2016 | Park Lane LS3 1EP Leeds One England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 09 apr 2014 Consegnato il 16 apr 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 19 dic 2012 Consegnato il 07 gen 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The sum of £20,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 mag 2005 Consegnato il 26 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0