ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED

ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04153470
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O James Cowper Kreston The White Building
    1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STARGLADE PARK DEVELOPMENTS LIMITED25 nov 200425 nov 2004
    STARGLADE DEVELOPMENTS LIMITED05 feb 200105 feb 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2023
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2021

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al14 mag 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma28 mag 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al14 mag 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    6 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    6 pagineAM06

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    6 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    26 pagineAM10

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    47 pagineAM03

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Indirizzo della sede legale modificato da Royale House 1550 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AG England a C/O James Cowper Kreston the White Building 1-4 Cumberland Place Southampton SO15 2NP in data 26 ago 2023

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2022 al 31 mar 2023

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 041534700019 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2021

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jason Mark Williams il 01 dic 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Gary Meredith il 01 dic 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Lee Jack Bull il 01 dic 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Bull il 01 dic 2021

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2020

    13 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Royale Parks Limited come persona con controllo significativo il 14 mag 2021

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Royale Parks Limited come persona con controllo significativo il 14 mag 2021

    2 paginePSC05

    Chi sono gli amministratori di ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BULL, Robert Lee Jack
    The White Building
    1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    C/O James Cowper Kreston
    Amministratore
    The White Building
    1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    C/O James Cowper Kreston
    EnglandBritish240346910002
    BULL, Robert
    The White Building
    1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    C/O James Cowper Kreston
    Amministratore
    The White Building
    1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    C/O James Cowper Kreston
    EnglandBritish155061060011
    MEREDITH, Stephen Gary
    The White Building
    1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    C/O James Cowper Kreston
    Amministratore
    The White Building
    1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    C/O James Cowper Kreston
    EnglandBritish262233680001
    WILLIAMS, Jason Mark
    The White Building
    1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    C/O James Cowper Kreston
    Amministratore
    The White Building
    1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    C/O James Cowper Kreston
    EnglandBritish194866870003
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Segretario nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    VANCE HARRIS SERVICES LIMITED
    c/o Core Law
    Beacon Road
    TN6 1AF Crowborough
    1
    East Sussex
    England
    Segretario
    c/o Core Law
    Beacon Road
    TN6 1AF Crowborough
    1
    East Sussex
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4153470
    72110640001
    COOPER, Royston
    1 Bird Cottages
    Rowfold Nurseries
    RH14 9DD Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    1 Bird Cottages
    Rowfold Nurseries
    RH14 9DD Billingshurst
    West Sussex
    EnglandBritish120878950001
    FORWARD, Alan Stephen
    Oak Tree Lane
    BN23 8FB Eastbourne
    Eastbourne Heights
    East Sussex
    Amministratore
    Oak Tree Lane
    BN23 8FB Eastbourne
    Eastbourne Heights
    East Sussex
    EnglandBritish58420190007
    FORWARD, Keith Alan
    2 Forest Fold Cottages
    London Road
    TN6 1TJ Crowborough
    Sussex
    Amministratore
    2 Forest Fold Cottages
    London Road
    TN6 1TJ Crowborough
    Sussex
    British69854450006
    TURNOCK, Karen
    116 Fermor Way
    TN6 3BJ Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    116 Fermor Way
    TN6 3BJ Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish80285980002
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Amministratore delegato nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Parkway
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    Royale House 1550
    Hampshire
    England
    06 apr 2016
    Parkway
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    Royale House 1550
    Hampshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09330072
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 07 set 2018
    Consegnato il 20 set 2018
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold property known as south hants country park, blackhouse lane, north boarhunt, fareham PO17 6JS and registered at the land registry under title number HP672339.. The freehold property known as land on the south side of stockers lodge, bere farm lane, north boarhunt, fareham and registered at the land registry under title number HP754879.. The freehold property known as land lying to the north west of blackhouse lane, north boarhunt, fareham and registered at the land registry under title number HP806989.. The freehold property known as s I s chemicals LTD, southwick road, fareham P017 6JP and registered at the land registry under title number HP511426.. The freehold property known as stalmine hall caravan park, hall gate lane, stalmine FY6 0LD and registered at the land registry under title number LA884022.. The freehold property known as croft park caravan site, wigan road, leyland PR25 5UF and registered at the land registry under title number LAN22846. The freehold property known as land at carter place hall, hall park, haslingden, rossendale and registered at the land registry under title number LAN26121.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Icg-Longbow Investment No. 5 S.À R.L.
    Transazioni
    • 20 set 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 29 ago 2018
    Consegnato il 31 ago 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Security over cash deposits.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 ott 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2017
    Consegnato il 01 giu 2017
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Asset Advantage Limited
    Transazioni
    • 01 giu 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 gen 2017
    Consegnato il 16 gen 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold property known as 0.73 acres of land off south wick road, fareham registered at h m land registry with title number HP511426.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 dic 2015
    Consegnato il 22 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed and floating charge over all assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 dic 2015
    Consegnato il 09 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold property known as croft park wigan road leyland preston lancashire registered with title number LAN22846.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 dic 2015
    Consegnato il 09 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold property known as wickham court black house lane north boarhunt fareham hampshire registered with title numbers HP754879 and HP672339.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 dic 2015
    Consegnato il 09 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold property known as stalmine hall park hallgate lane poulton le fylde lancashire with title number LA884022.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 dic 2015
    Consegnato il 09 dic 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold property known as carter hall park blackburn road haslington lancashire registered with title number LAN26121.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 feb 2008
    Consegnato il 23 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 mar 2006
    Consegnato il 21 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a smugglers leap mount pleasant minster kent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 ott 2005
    Consegnato il 09 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land part of and k/a carter hall place, haslingden, rossendale, lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2005
    Consegnato il 07 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a croft park,wiggan road,leyland,lancashire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 08 ago 2005
    Consegnato il 09 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a vines mobile home park back lane warton preston lancashire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 lug 2005
    Consegnato il 09 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage deed
    Creato il 02 gen 2003
    Consegnato il 08 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £139,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Silvergrove innhams wood crowborough east sussex t/no: ESX254262.
    Persone aventi diritto
    • Munir Abdelnoor and Pamela Mavis Abdelnoor
    Transazioni
    • 08 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 ago 2001
    Consegnato il 30 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Silvergrove innhams wood crowborough east sussex TN6 1TE.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 30 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 2001
    Consegnato il 27 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a "the retreat" cross in hand heathfield east sussex.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 27 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 29 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 owlsbury cottages jarvis brook crowborough east sussex t/no;-ESX126874.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 mar 2001
    Consegnato il 05 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 05 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ROYALE PARK HOME ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 ago 2023Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul David Allen
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor, 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    2nd Floor, 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Sandra Lillian Mundy
    The White Building 1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    The White Building 1-4 Cumberland Place
    SO15 2NP Southampton
    Hampshire
    Paul Davies
    5th Floor Holborn Gate 330 High Holborn
    WC1V 7QH London
    Praticante
    5th Floor Holborn Gate 330 High Holborn
    WC1V 7QH London
    Thomas Charles Russell
    The White Building 1-4 Cumberland Place
    Southampton
    Praticante
    The White Building 1-4 Cumberland Place
    Southampton

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0