FLAMEWALL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFLAMEWALL LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04164098
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di FLAMEWALL LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova FLAMEWALL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    161 Drury Lane
    WC2B 5PN London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FLAMEWALL LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per FLAMEWALL LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al05 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma19 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al05 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per FLAMEWALL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Martin Francis Magee come amministratore in data 28 feb 2025

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2023

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2022

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2021

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Es Enterprise Holdings Limited come persona con controllo significativo il 31 ago 2021

    2 paginePSC02

    Cessazione di Larkfield Enterprises Limited come persona con controllo significativo il 31 ago 2021

    1 paginePSC07

    Indirizzo della sede legale modificato da 100 George Street London W1U 8NU England a 161 Drury Lane London WC2B 5PN in data 20 set 2021

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Herbert Surphlis il 24 mar 2021

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2019

    8 pagineAA

    Nomina di Mrs Ita Gillis come segretario in data 02 lug 2020

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di James Stephen Higgins come segretario in data 02 lug 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Mary Margaret Laverty come amministratore in data 02 giu 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Emelda Catherine O'neill come amministratore in data 02 giu 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2017

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Herbert Surphlis il 01 nov 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr James Stephen Higgins il 20 lug 2017

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di FLAMEWALL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GILLIS, Ita
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    Segretario
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    272934810001
    LAVERTY, Eamonn Francis
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Amministratore
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director164594500001
    LAVERTY, Mary Margaret
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    Amministratore
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director100394510001
    MCALEER, Seamus (James)
    130 Drum Road
    BT80 9DN Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Amministratore
    130 Drum Road
    BT80 9DN Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director159942180001
    O'NEILL, Emelda Catherine
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    Amministratore
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director110462690001
    SURPHLIS, Stephen Herbert
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    Amministratore
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    Northern IrelandBritishCompany Director116861100031
    HIGGINS, James Stephen
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Segretario
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Northern IrishCompany Secretary116620060001
    SCULLION, Colum
    South House
    Ballynorthland Park
    BT71 6DY Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Segretario
    South House
    Ballynorthland Park
    BT71 6DY Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    British145273430001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    MAGEE, Martin Francis
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    Amministratore
    Drury Lane
    WC2B 5PN London
    161
    England
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director105879500001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FLAMEWALL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Es Enterprise Holdings Limited
    Dungannon Road
    BT80 8TL Cookstown
    17-19
    Northern Ireland
    31 ago 2021
    Dungannon Road
    BT80 8TL Cookstown
    17-19
    Northern Ireland
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneNorthern Ireland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneNorthern Ireland
    Numero di registrazioneNi681470
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Larkfield Enterprises Limited
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    06 apr 2016
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione08097598
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    FLAMEWALL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 ott 2009
    Consegnato il 04 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 04 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 ott 2005
    Consegnato il 26 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a the newgate centre, newcastle upon tyne, t/no TY203528 and the property k/a the swallow hotel, newgate shopping centre, newcastle upon tyne t/no TY256967 and the property k/a storage area, newgate shopping centre, newcastle upon tyne, t/no TY256968 for further property charged please refer to the form 395. and all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 26 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 14 feb 2005
    Consegnato il 22 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as city square house wellington street leeds t/n WYK472381,. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 22 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 feb 2003
    Consegnato il 22 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a castle street car park scotswood road newcastle upon tyne tyne and wear and land at scotswood road newcastle upon tyne tyne and wear t/nos: TY366633 and TY380721.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 22 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2001
    Consegnato il 29 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in relation to (I) the development or (ii) the property or (iii) under this deed or (iv) under an assignment of even date (all terms as defined)
    Brevi particolari
    The property being all the land at cattle market, newcastle upon tyne, comprised within t/nos TY374272, TY366633 and TY165415.by way of assignment the benefit of any covenants, agreement or undertaking for road making or for the payment of road charges or private street improvement or drainage expenses, any other covenant, agreement, undertaking, charge, right or remedy, all rights of the mortgagor to be paid or to receive compensation.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jurys Hotel Management UK Limited
    Transazioni
    • 29 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of assignment of a development agreement
    Creato il 19 ott 2001
    Consegnato il 29 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in respect of (i)the development (ii) under this deed and (iii) under a legal charge between the company and the chargee of even date
    Brevi particolari
    The full benefit of all its right title and interest in and under the development agreement including for the avoidance of doubt but without limitation all rights of the developer to sue or take action in respect of any breach of the obligations of international centre for life (property) limited contained in the development agreement.
    Persone aventi diritto
    • Jurys Hotel Management (UK) Limited
    Transazioni
    • 29 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2001
    Consegnato il 24 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The costs of designing constructing and completing the works more particularly described in the development agreement (as defined) ("the works") in accordance with an agreement dated 6 july 2001 and made between international centre for life (property) limited (1) the company (2) and mcaleer & rushe limited (3) as amended by a supplemental agreement made between the same parties dated 19 october 2001 ("the development agreement") including professional fees statutory fees for obtaining any approvals for them and the sums payable under paragraph 3.2 of the second schedule of a planning agreement dated 19 october 2001
    Brevi particolari
    All that freehold land at cattle market newcastle upon tyne title numbers TY165415 TY374272 and TY366633 including all fixtures and fittings and fixed plant and machinery on it held or owned by the company the benefit of the appointments the building documents and the building contract as defined in the development agreement and all other contracts deeds undertakings agreements rights warranties securities covenants guarantees bonds and indemnities of any nature now or at any time enjoyed of held by the company and relating to the nscp site (as defined in the development agreement). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • International Centre for Life (Property) Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8TH october 2001
    Creato il 19 set 2001
    Consegnato il 13 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    60 to 70 and 82 jamaica street glasgow t/no: GLA35078.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 13 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0