TIKIT GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | TIKIT GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04164203 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TIKIT GROUP LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TIKIT GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 55 Baker Street W1U 7EU London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TIKIT GROUP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TIKIT GROUP PLC | 20 feb 2001 | 20 feb 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TIKIT GROUP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per TIKIT GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon John Hill il 01 nov 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 lug 2017 | 14 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 dic 2016 | 8 pagine | 4.68 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di James Antony Ford come amministratore in data 01 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Peter Gray come amministratore in data 29 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Peter Gray come amministratore in data 29 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 81 Newgate Street London EC1A 7AJ a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 29 dic 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 22 ott 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Katherine Ainley come amministratore in data 08 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Sebastian Courtney Wood come amministratore in data 31 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy John Springham come amministratore in data 31 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Hall come amministratore in data 31 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Adam John Baird come amministratore in data 04 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TIKIT GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED | Segretario | Newgate Street EC1A 7AJ London 81 United Kingdom |
| 148979030001 | ||||||||||
AINLEY, Katherine Esther | Amministratore | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9f United Kingdom | England | British | Bt Executive | 193945240001 | ||||||||
HILL, Simon John | Amministratore | 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Ppa9f Bt Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 64076140008 | ||||||||
BAKER, Edward Matthew Scott | Segretario | 3 Sandiway WA16 8BU Knutsford Cheshire | British | 4668730004 | ||||||||||
KENT, Michael William Bates | Segretario | Moorside Lane Holbrook DE56 0TW Derby 36 Derbyshire | British | Company Director | 131127690001 | |||||||||
PAUL JAMES, Giuffredi | Segretario | 26 Grove Avenue TW1 4HY Twickenham Middlesex | British | Director | 114159750001 | |||||||||
PEARSON, Anthony | Segretario | Endover House Private Road Rodborough Common GL5 5BT Stroud Gloucestershire | British | Chartered Accountant | 50419790002 | |||||||||
BAIRD, Adam John | Amministratore | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 133855430001 | ||||||||
BRIANT, Nicholas Adrian | Amministratore | 24 Neville Avenue KT3 4SN New Malden Surrey | British | Solicitor | 25460950002 | |||||||||
DAVIS, Neville | Amministratore | Manyons Church Lane Barkway SG8 8EJ Royston Hertfordshire | England | British | Company Director | 17829820001 | ||||||||
FORD, James Antony | Amministratore | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 188688900001 | ||||||||
GRAY, Richard Peter | Amministratore | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | England | British | Finance Director | 178364970001 | ||||||||
HALL, Adam Christian Roderick | Amministratore | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 105823640002 | ||||||||
HALL, Stephen | Amministratore | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | United Kingdom | British | Strategy & Business Development Director | 175339310001 | ||||||||
HOBDAY, David Arthur | Amministratore | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | United Kingdom | British | Bt Executive | 182038490001 | ||||||||
KENT, Michael William Bates | Amministratore | Moorside Lane Holbrook DE56 0TW Derby 36 Derbyshire | United Kingdom | British | Company Director | 131127690001 | ||||||||
LUMSDEN, David Stuart | Amministratore | Ralliwood Road KT21 1DD Ashtead 39 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 76193700002 | ||||||||
MCGOUN, Michael Frederick | Amministratore | The Old Rectory Church Lane Mobberley WA16 7RD Knutsford Cheshire | England | British | Director | 8300340001 | ||||||||
PAUL JAMES, Giuffredi | Amministratore | 26 Grove Avenue TW1 4HY Twickenham Middlesex | British | Director | 114159750001 | |||||||||
PEARSON, Anthony | Amministratore | Endover House Private Road Rodborough Common GL5 5BT Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 50419790002 | ||||||||
PRICE, Richard Ralph | Amministratore | 13 Victoria Grove W8 5RW London | United Kingdom | British | Chairman | 89571880001 | ||||||||
SPRINGHAM, Timothy John | Amministratore | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | United Kingdom | British | Business Executive | 87907670001 | ||||||||
WOOD, Sebastian Courtney | Amministratore | 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d Bt Centre | England | British | Chartered Accountant | 149792160001 | ||||||||
A B & C SECRETARIAL LIMITED | Amministratore | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 38962110003 | |||||||||||
INHOCO FORMATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
TIKIT GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 02 apr 2008 Consegnato il 08 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge of securities (UK) | Creato il 02 apr 2008 Consegnato il 08 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge any stocks shares bonds or warrants or securities (certificated or uncertificated) which are from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company to the bank by reference to the charge of securities or in respect of which title or the relevant account entries is/are held in the name of or to the order of the bank or its nominee or in respect of which the relevant certificates or other title documents are deposited with or held to the order of the bank or its nominee together with all income derived from and rights attaching to the same. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
TIKIT GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0