CPS NUMBER 4 LIMITED

CPS NUMBER 4 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCPS NUMBER 4 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04165716
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CPS NUMBER 4 LIMITED?

    • Trasporto merci via acqua costiera e marittima (50200) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova CPS NUMBER 4 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No.1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CPS NUMBER 4 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALNERY NO.2162 LIMITED22 feb 200122 feb 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di CPS NUMBER 4 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CPS NUMBER 4 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Tui Travel House Crawley Business Quarter Fleming Way Crawley West Sussex RH10 9QL a No.1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 01 ott 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 01 set 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mag 2015

    Stato del capitale al 14 mag 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    4 pagineAA

    Nomina di Mark Hattendorf come amministratore in data 19 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Wilfried Rau come amministratore in data 30 nov 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mag 2014

    Stato del capitale al 14 mag 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Andrew John come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012

    4 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Joyce Walter il 09 mag 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Lloyd John il 21 giu 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 48a Cambridge Road Hapag-Lloyd House Barking Essex IG11 8HH* in data 28 giu 2010

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Joyce Walter come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di CPS NUMBER 4 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WALTER, Joyce
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    Segretario
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    152272050001
    HATTENDORF, Mark
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    GermanyGermanAccountant183404720001
    WALTER, Joyce
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Secretary76169540003
    BAKER, John Michael
    Pedlars
    The Chase
    KT20 6HZ Kingswood
    Surrey
    Segretario
    Pedlars
    The Chase
    KT20 6HZ Kingswood
    Surrey
    Canadian110901170001
    HILL, Elliot Robert Greatrex
    Flat 1
    143 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    Segretario
    Flat 1
    143 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    British99461490001
    MANSFELD, Thomas
    Zikadenweg
    FOREIGN 22043 Hamburg
    19e
    Germany
    Segretario
    Zikadenweg
    FOREIGN 22043 Hamburg
    19e
    Germany
    German117835010002
    SHARMAN, Carl John
    6 Days Green
    Capel St Mary
    IP9 2HZ Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    6 Days Green
    Capel St Mary
    IP9 2HZ Ipswich
    Suffolk
    BritishChartered Accountant74436380003
    SHORT, Karen Margot
    The Tythe Barn
    TN21 9RG Rushlake Green
    East Sussex
    Segretario
    The Tythe Barn
    TN21 9RG Rushlake Green
    East Sussex
    BritishAccountant78988930002
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Segretario nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BOYLAN, Alan Francis
    361 Chambersbury Lane
    HP3 8LW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    361 Chambersbury Lane
    HP3 8LW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishDirector105598290003
    HARDS, Glenn
    36 Ratton Drive
    BN20 9BS Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    36 Ratton Drive
    BN20 9BS Eastbourne
    East Sussex
    BritishDirector102419860001
    JOHN, Andrew Lloyd
    Crawley Business Quarter
    Fleming Way
    RH10 9QL Crawley
    Tui Travel House
    West Sussex
    Amministratore
    Crawley Business Quarter
    Fleming Way
    RH10 9QL Crawley
    Tui Travel House
    West Sussex
    United KingdomBritishLawyer75467790004
    KNIGHTLEY, Ian Geoffrey
    5 Old Rectory Gardens
    Occold
    IP23 7PD Eye
    Suffolk
    Amministratore
    5 Old Rectory Gardens
    Occold
    IP23 7PD Eye
    Suffolk
    BritishDirector74138000001
    KRANICH, Ulrich
    Weidenkamp 4
    Handorf
    21447
    Germany
    Amministratore
    Weidenkamp 4
    Handorf
    21447
    Germany
    GermanyGermanDirector108535400001
    NICKLIN, David Royston
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    Amministratore
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    BritishDirector78465650001
    NICKLIN, David Royston
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    Amministratore
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    BritishDirector78465650001
    RAU, Wilfried
    Hannover
    Bischofsholer Damm 34
    30173
    Germany
    Amministratore
    Hannover
    Bischofsholer Damm 34
    30173
    Germany
    GermanyGermanDirector136733410001
    REEVE, Michael
    11 Tiberius Gardens
    CM8 1HJ Witham
    Essex
    Amministratore
    11 Tiberius Gardens
    CM8 1HJ Witham
    Essex
    EnglandBritishDirector60778110001
    TORRENS, Iain William
    34 Church Avenue
    East Sheen
    SW14 8NN London
    Amministratore
    34 Church Avenue
    East Sheen
    SW14 8NN London
    BritishDirector83364810001
    WALDING, Keith John
    Kintail
    Halldore Hill
    SL6 9EX Cookham
    Berkshire
    Amministratore
    Kintail
    Halldore Hill
    SL6 9EX Cookham
    Berkshire
    BritishDirector46199600003
    WEBBER, Ian James
    The Farmyard
    Pearsons Green
    TN12 7DE Brenchley
    Kent
    Amministratore
    The Farmyard
    Pearsons Green
    TN12 7DE Brenchley
    Kent
    BritishDirector54611490002
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001

    CPS NUMBER 4 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Tripartitie general assignment
    Creato il 04 set 2002
    Consegnato il 06 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party on an account current under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned contract rights and the proceeds thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC
    Transazioni
    • 06 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General assignment
    Creato il 04 set 2002
    Consegnato il 06 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party on an account current under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The earnings of the ship; the insurances of the ship; any charter; any charter guarantee and any requisition compensation for the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC
    Transazioni
    • 06 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 04 set 2002
    Consegnato il 06 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party on an account current under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the vessel "contship aurora" documented in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 906102.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC
    Transazioni
    • 06 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First priority statutory ship mortgage
    Creato il 04 set 2002
    Consegnato il 06 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party on an account current under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the vessel "contship aurora" documented in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 906102. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC
    Transazioni
    • 06 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Predelivery security assignment deed
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 12 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Predelivery security assignment deed
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 12 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Predelivery security assignment deed
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 12 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Predelivery security assignment deed
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 12 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee
    Brevi particolari
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Predelivery security assignment deed
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 12 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 28 mag 2002
    Consegnato il 30 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the chargee or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the undertaking, assets and rights of the company both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Citibank International PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CPS NUMBER 4 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 set 2015Inizio della liquidazione
    08 feb 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0