LEATHERBAY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEATHERBAY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04166893
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEATHERBAY LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova LEATHERBAY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Forge Lane
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEATHERBAY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per LEATHERBAY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 feb 2024 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Repton House Bretby Business Park, Ashby Road Burton upon Trent Staffordshire DE15 0YZ England a Forge Lane Killamarsh Sheffield S21 1BA in data 20 set 2023

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Simon David Martle come amministratore in data 01 ago 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 feb 2023 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    1 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 041668930015, creata il 31 ago 2022

    90 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 041668930014, creata il 20 giu 2022

    96 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 feb 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    1 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Helen Barrett-Hague il 29 set 2021

    2 pagineCH01

    Nomina di Mrs Helen Barrett-Hague come amministratore in data 28 set 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Molyneux come segretario in data 28 set 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Helen Barrett-Hague come segretario in data 28 set 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ian Molyneux come amministratore in data 28 set 2021

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon David Martle il 09 set 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    1 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 041668930009 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Simon David Martle come amministratore in data 01 set 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael Joseph Quinn come amministratore in data 13 mar 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lisa Marie Oxnard come amministratore in data 13 mar 2020

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LEATHERBAY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARRETT-HAGUE, Helen
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    Segretario
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    287748360001
    BARRETT-HAGUE, Helen
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    Amministratore
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    EnglandBritishSolicitor287804380001
    QUINN, Michael Joseph
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    Amministratore
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    IrelandIrishCeo268174890001
    GREGSON, Henry William
    47 Sutherland Place
    W2 5BY London
    Segretario
    47 Sutherland Place
    W2 5BY London
    BritishFund Manager141581500001
    JACKSON, Howard Watson
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    Segretario
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    British34443700002
    MOLYNEUX, Ian
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Segretario
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    British164532270001
    TILLEY, Michael John
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    Segretario
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    BritishCompany Secretary60728390001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    ASTON, Stephen Mark
    The Gables
    Rowley Avenue
    ST17 9AA Stafford
    Amministratore
    The Gables
    Rowley Avenue
    ST17 9AA Stafford
    United KingdomBritishFinance Director287327450002
    ELLIS, William Michael
    Manor Drive
    Worthington
    LE65 1RN Ashby-De-La-Zouch
    The Manor House
    Leicestershire
    Amministratore
    Manor Drive
    Worthington
    LE65 1RN Ashby-De-La-Zouch
    The Manor House
    Leicestershire
    United KingdomAmericanChief Executive Officer134919220003
    GIFFIN, David Ronald
    21 Barnton Gardens
    EH4 6AE Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    21 Barnton Gardens
    EH4 6AE Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishBanker65377070001
    GREGSON, Henry William
    47 Sutherland Place
    W2 5BY London
    Amministratore
    47 Sutherland Place
    W2 5BY London
    United KingdomBritishFund Manager141581500001
    HINKS, Duncan Andrew
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer164530200005
    ISAACS, Paul
    136 Mill Lane
    B93 8NZ Bentley Heath
    West Midlands
    Amministratore
    136 Mill Lane
    B93 8NZ Bentley Heath
    West Midlands
    BritishVenture Capitalist84187490001
    JACKSON, Howard Watson
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    Amministratore
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    United KingdomBritishLawyer34443700002
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    LEWIS, Eric James
    Rowan House
    32 Nursery Lane, Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Rowan House
    32 Nursery Lane, Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishChief Executive75455450001
    MARTLE, Simon David
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer151541840002
    MOLYNEUX, Ian
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritishSolicitor75284220004
    OXNARD, Lisa Marie
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer253562580001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SCHURCH, Michael John
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    Amministratore
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector42065200003
    RBEF LIMITED
    42 St Andrew Square
    EH2 2AD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    42 St Andrew Square
    EH2 2AD Edinburgh
    Midlothian
    94883700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LEATHERBAY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    06 apr 2016
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04167030
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per LEATHERBAY LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    27 feb 201728 feb 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    LEATHERBAY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 ago 2022
    Consegnato il 03 set 2022
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 03 set 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 giu 2022
    Consegnato il 05 lug 2022
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Americas Llc (As Security Agent)
    Transazioni
    • 05 lug 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 mar 2020
    Consegnato il 11 mar 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 11 mar 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 mar 2020
    Consegnato il 10 mar 2020
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Americas Llc (As Security Agent)
    Transazioni
    • 10 mar 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2017
    Consegnato il 03 ott 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of America, N.A.
    Transazioni
    • 03 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 apr 2013
    Consegnato il 18 apr 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse Ag, Cayman Islands Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 18 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 apr 2013
    Consegnato il 18 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse Ag, Cayman Islands Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 18 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 set 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 apr 2013
    Consegnato il 18 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of America,N.A. as Security Agent
    Transazioni
    • 18 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 feb 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee increase deed in relation to a £50M pik facility agreement dated 3 april 2007 and
    Creato il 16 mag 2007
    Consegnato il 01 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 01 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee increase deed in relation to a £57.5M mezzanine facility agreement dated 3 april 2007 and
    Creato il 16 mag 2007
    Consegnato il 01 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 01 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee increase deed in relation to a £832.5M senior facilities agreement dated 3 april 2007 and
    Creato il 16 mag 2007
    Consegnato il 01 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 01 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 mag 2007
    Consegnato il 23 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 23 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 mag 2006
    Consegnato il 16 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transazioni
    • 16 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A composite guarantee and debenture between acornplace limited ("acornplace), the company, clovepark limited, rcg holdings limited (the "parent") (together the "newcos") and the security agent (as defined)
    Creato il 20 ago 2001
    Consegnato il 28 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee and the finance parties or any of them including, without limitation, all monies, obligations and liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the finance documents (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. on Its Own Behalf and on Behalfof Each of the Finance Parties in Its Capacity as Security Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 28 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 28 apr 2001
    Consegnato il 09 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the interim facility letter (as defined therein) and under or pursuant to any of the finance documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. on Behalf of Itself, the Finance Parties Andthe Banks and Financial Institutions from Time to Time Parties to the Finance Documents
    Transazioni
    • 09 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0