REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED

REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione controllata
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04171884
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 2274 LIMITED02 mar 200102 mar 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al28 feb 2011
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 nov 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2010

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al02 mar 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma16 mar 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    legacy

    3 pagineLQ01

    legacy

    2 pagineLQ02

    Cessazione della carica di Valad Secretarial Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Valsec Director Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christian Bearman come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineLQ01

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mar 2011

    Stato del capitale al 07 mar 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 09 dic 2010

    3 pagineCH04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2010

    7 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 16 set 2010

    3 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 02 mar 2010

    2 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 02 mar 2010

    2 pagineCH04

    Nomina di Mr Christian James Alexander Bearman come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Maddy come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di James Edward Maddy come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Didier Tandy come amministratore

    2 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Didier Michel Tandy il 22 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Didier Michel Tandy il 22 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Didier Michel Tandy il 07 ott 2009

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2009

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    9 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    6 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Segretario
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Segretario
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    NAIK, Varsha
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    Segretario
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    BritishGroup Financial Controller101693390001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Segretario
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520001
    BEARMAN, Christian James Alexander
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishChief Operating Officer-Europe110436370002
    CORLETT, Robert John
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor72399980002
    GILMAN, Peter John
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director35528040001
    LIGHTBODY, Bruce Robson
    148 Almsford Drive
    HG2 8EE Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    148 Almsford Drive
    HG2 8EE Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor75214270001
    MADDY, James Edward
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    Amministratore
    Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House 20
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant137459000001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Controller56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    BritishChartered Surveyor109250000001
    OLIVER, Paul Francis
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    Amministratore
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    United KingdomBritishChief Executive14735150002
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Amministratore
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritishChartered Accountant41925000003
    TANDY, Didier Michel
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    TUTTON, Jeremy John
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    Amministratore
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    BritishFinancial Controller100816670001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5307786
    102622300002

    REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture and guarantee
    Creato il 28 giu 2006
    Consegnato il 12 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company the chargors and each of them to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property at plot 1175 thorpe park leeds t/n WYK734083, part of plot 1250 thorpe park leeds t/n WYK691297, plot 2100 thorpe park leeds t/n WYK691298, for details of further properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capmark Bank Europe PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 127 mag 2011Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 115 mar 2013Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
    • 115 mar 2013Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
      • Numero di pratica 1
    Debenture
    Creato il 10 apr 2003
    Consegnato il 11 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 07 mar 2003
    Consegnato il 17 mar 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2001
    Consegnato il 10 apr 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 2200 (b) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 1250 thorpe park leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2001
    Consegnato il 10 apr 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 2200 (b) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)

    REMOTE PROPERTIES 2200 (B) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Hugh Lawrence Dorins
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Ricevitore/gestore
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Robert Stokely
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Ricevitore/gestore
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Colin Richard Jennings
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Ricevitore/gestore
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0