PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED

PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04173882
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    103 Clarendon Road
    Leeds
    LS2 9DF West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PHOTOPHARMICA LIMITED06 mar 200106 mar 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2015

    Stato del capitale al 23 gen 2015

    • Capitale: GBP 65,107.6
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 feb 2014

    Stato del capitale al 06 feb 2014

    • Capitale: GBP 65,107.6
    SH01

    Nomina di Ip2Ipo Services Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Stephen Lyon come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Stephen Felstead come amministratore

    2 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed photopharmica LIMITED\certificate issued on 13/02/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name13 feb 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 11 feb 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Cessazione della carica di Michael Asbury come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Holdcroft come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Dr Stephen John Felstead come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Wilding come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2011

    9 pagineAA

    Nomina di Ip2Ipo Services Limited come amministratore

    3 pagineAP02

    Cessazione della carica di Samuel Williams come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2010

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    IP2IPO SERVICES LIMITED
    Cornhill
    EC3V 3ND London
    24
    Segretario
    Cornhill
    EC3V 3ND London
    24
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5325867
    122951520001
    BROWN, Stanley, Professor
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishUniversity Professor74714120002
    LYON, Stephen John
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant Biochemis83882200002
    IP2IPO SERVICES LIMITED
    Cornhill
    EC3V 3ND London
    24
    England
    Amministratore
    Cornhill
    EC3V 3ND London
    24
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04072979
    122951520001
    LYON, Stephen John
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant Biochemis83882200002
    SMITH, Malcolm Albert
    21 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    21 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    West Yorkshire
    British58240110001
    ASBURY, Michael John
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector94640540002
    FELSTEAD, Stephen John, Dr
    Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    103
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    103
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector170081000001
    HOLDCROFT, David, Professor
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Leeds Innovation Centre
    103 Clarendon Road
    LS2 9DF Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishConsultant32847980003
    MARSHALL, Valerie Margaret
    2 Farnaby Drive
    TN13 2LQ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    2 Farnaby Drive
    TN13 2LQ Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director74642590004
    RAWLINS, Peter Jeremy
    The Mill House
    Leathley Lane, Leathley
    LS21 2JZ Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Mill House
    Leathley Lane, Leathley
    LS21 2JZ Otley
    West Yorkshire
    BritishManaging Director68104690002
    WILDING, Ian, Dr
    10 Glebe Street
    NG11 6JS Beeston
    Nottinghamshire
    Amministratore
    10 Glebe Street
    NG11 6JS Beeston
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishPharmacist111933510001
    WILLIAMS, Samuel Cameron
    60 Cannon Street
    EC4N 6NP London
    Amministratore
    60 Cannon Street
    EC4N 6NP London
    United KingdomBritishChief Executive Officer149546430001
    IP2IPO SERVICES LIMITED
    24 Cornhill
    EC3V 3ND London
    Amministratore
    24 Cornhill
    EC3V 3ND London
    122951520001

    PHOTOPHARMICA LEEDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment
    Creato il 17 mag 2007
    Consegnato il 25 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the assignor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right,title and interest under the security and the guarantee together with all rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ip Group PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 13 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Vida Capital Partners Limited
    Transazioni
    • 13 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life assurance policy
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 13 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to a life assurance policy taken out by the company over the life of john lyon dated 02/05/03 policy number 2003030 the amount assured being the sum of £1,500,000 with the kilm life syndicate. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Vida Capital Partners Limited
    Transazioni
    • 13 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life assurance policy
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 13 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its right title and interest in and to a life assurance policy taken out by the company over the life of stanley brown dated 02/05/03 policxy number SP0204986675 the amount assured being the sum of £1,600.00 with skandia life. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Vida Capital Partners Limited
    Transazioni
    • 13 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0