BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED

BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04175866
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    • Servizi di rappresentanza dei media (73120) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PROMOTION SPACE LIMITED24 mar 200324 mar 2003
    CPL HOLDINGS LIMITED29 ago 200129 ago 2001
    PARTNERSHIPS@ LIMITED08 mar 200108 mar 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mar 2018

    16 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mar 2017

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mar 2016

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mar 2015

    11 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:block transfer order - replacement of liquidator
    47 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 mar 2014

    16 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 ott 2013

    13 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    8 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    35 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2Nd Floor Egginton House 25-28 Buckingham Gate London SW1E 6LD England* in data 18 apr 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 7Th Floor South Artillery House 11-19 Artillery Row London London SW1P 1RT England* in data 27 mar 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Ms Michelle De Young come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Soanes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sean Fay come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Sandfield House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AR* in data 13 set 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 mar 2012

    Stato del capitale al 22 mar 2012

    • Capitale: GBP 1,188.61
    SH01

    Chi sono gli amministratori di BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DE YOUNG, Michelle Anna-Lisa
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Amministratore
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandBritish140102770001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Segretario
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    British22089740001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Segretario
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    British102300760001
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    OCS CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    Segretario
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    71518050017
    COCKSHUTT, Diane
    2 Place Road
    WA14 4HH Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    2 Place Road
    WA14 4HH Altrincham
    Cheshire
    British75151590001
    FAY, Sean Ernan
    Floor South Artillery House
    11-19 Artillery Row London
    SW1P 1RT London
    7th
    England
    Amministratore
    Floor South Artillery House
    11-19 Artillery Row London
    SW1P 1RT London
    7th
    England
    United KingdomIrish84925400001
    FUSCO, Robert
    3 Blenheim Close
    SK9 2DN Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    3 Blenheim Close
    SK9 2DN Wilmslow
    Cheshire
    British105982320001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    UkBritish22089740001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    UkBritish22089740001
    HOWARD, Peter
    Lower Stone Ridge
    Green Lane, Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Lower Stone Ridge
    Green Lane, Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish77112140001
    HUGHES, Stephan Michael
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish95176800002
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish102300760001
    SOANES, Paul Henry
    Sparrow Row
    Chobham
    GU24 8TA Woking
    Woodside
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Sparrow Row
    Chobham
    GU24 8TA Woking
    Woodside
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish68377030007
    SOAR, Guy Jason
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    Amministratore
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    United KingdomBritish96671300002
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    OCS DIRECTORS LIMITED
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    Amministratore delegato nominato
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    900021490001

    BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 giu 2010
    Consegnato il 08 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to beocme due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Transazioni
    • 08 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 nov 2009
    Consegnato il 13 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 14 lug 2009
    Consegnato il 31 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited
    Transazioni
    • 31 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 07 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 07 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 apr 2008
    Consegnato il 07 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 07 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 apr 2007
    Consegnato il 11 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)

    BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 apr 2013Inizio dell'amministrazione
    28 mar 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    2
    DataTipo
    28 mar 2014Inizio della liquidazione
    16 gen 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Liquidatore proposto
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Liquidatore proposto
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Neville Side
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0