SANDCO 1158 LIMITED

SANDCO 1158 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSANDCO 1158 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04177818
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SANDCO 1158 LIMITED?

    • (7514) /

    Dove si trova SANDCO 1158 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Spectrum 6 Spectrum Business Park
    SR7 7TT Seaham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SANDCO 1158 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BUSINESS LINK TYNE AND WEAR LIMITED23 apr 200123 apr 2001
    SANDCO 697 LIMITED12 mar 200112 mar 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di SANDCO 1158 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SANDCO 1158 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Paul Callaghan come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alastair Angus Maccoll come amministratore

    2 pagineAP01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed business link tyne and wear LIMITED\certificate issued on 18/08/10
    4 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 ago 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2010

    Stato del capitale al 31 mar 2010

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2009

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Michael Callaghan il 12 nov 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    15 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    18 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di SANDCO 1158 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACCOLL, Alastair Angus
    Spectrum Business Park
    SR7 7TT Seaham
    Spectrum 6
    Amministratore
    Spectrum Business Park
    SR7 7TT Seaham
    Spectrum 6
    EnglandBritishDirector159593560001
    ALLAN, Peter Riddle
    5 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    5 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishSolicitor35573440001
    BROPHY, Daniel Martin
    15 Beatty Avenue
    NE2 3QN Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    15 Beatty Avenue
    NE2 3QN Newcastle Upon Tyne
    BritishCeo63067480001
    FIONDA, George David
    11 Hundale
    Hutton Rudby
    TS15 0DR Yarm
    North Yorkshire
    Segretario
    11 Hundale
    Hutton Rudby
    TS15 0DR Yarm
    North Yorkshire
    BritishFinance36179920001
    POWELL, Alison Wendy
    The Glasshouse, The Walled Garden
    Hartford Hall Estate
    NE22 6AG Bedlington
    Northumberland
    Segretario
    The Glasshouse, The Walled Garden
    Hartford Hall Estate
    NE22 6AG Bedlington
    Northumberland
    BritishAccountant111740090001
    TAYLOR, Lindsay Jane
    15 Farriers Close
    Pity Me
    DH1 5XY Durham
    County Durham
    Segretario
    15 Farriers Close
    Pity Me
    DH1 5XY Durham
    County Durham
    British112546500001
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    WARD HADAWAY COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sandgate House
    102 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario nominato
    Sandgate House
    102 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    900020010001
    ALLAN, Peter Riddle
    Valley View
    Iveston Lane
    DH8 7TD Consett
    County Durham
    Amministratore
    Valley View
    Iveston Lane
    DH8 7TD Consett
    County Durham
    BritishSolicitor35573440002
    ATKINSON, Keith Andrew
    10 Easby Close
    NE3 5LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    10 Easby Close
    NE3 5LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector36184740003
    BATER, Reginald
    19 Roxby Avenue
    TS14 8LF Guisborough
    Cleveland
    Amministratore
    19 Roxby Avenue
    TS14 8LF Guisborough
    Cleveland
    BritishBusiness Consultant13104680001
    BROPHY, Daniel Martin
    15 Beatty Avenue
    NE2 3QN Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    15 Beatty Avenue
    NE2 3QN Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishChief Executive63067480001
    CALLAGHAN, Paul Michael
    Spectrum Business Park
    SR7 7TT Seaham
    Spectrum 6
    Amministratore
    Spectrum Business Park
    SR7 7TT Seaham
    Spectrum 6
    United KingdomBritishDirector27780380004
    CALLAGHAN, Paul Michael
    41 Albert Street
    Western Hill
    DH1 4RJ Durham City
    Amministratore
    41 Albert Street
    Western Hill
    DH1 4RJ Durham City
    United KingdomBritishCompany Director27780380003
    CHAPMAN, Terence
    19 Mulberry Close
    Woodlands Glade, South Beach
    NE24 3XR Blyth
    Amministratore
    19 Mulberry Close
    Woodlands Glade, South Beach
    NE24 3XR Blyth
    EnglandBritishDirector153588600001
    DICKSON, Anthony David Rae, Professor
    Revelstone
    The Dene Allendale
    NE47 9PX Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Revelstone
    The Dene Allendale
    NE47 9PX Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishAcademic66274260001
    DIN, Suhail Ahmad
    15 Adderstone Crescent
    Jesmond
    NE2 2HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    15 Adderstone Crescent
    Jesmond
    NE2 2HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishHotelier57360610002
    DORMER, Ian Gareth
    16 Montagu Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    16 Montagu Avenue
    Gosforth
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishDirector23737010002
    EDGAR, Alison
    102 The Wills Building
    Coast Road
    NE7 7RP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    102 The Wills Building
    Coast Road
    NE7 7RP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishDirector Of Recruitment58234110002
    FIDLER, Peter Michael
    29 Wheatsheaf Court
    SR6 0RF Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    29 Wheatsheaf Court
    SR6 0RF Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishUniversity Vice Chancellor56812230003
    FORD, Robert Geoffrey
    The Gin Gan & Byre
    Aykley Heads Farm
    DH1 5AN Durham
    County Durham
    Amministratore
    The Gin Gan & Byre
    Aykley Heads Farm
    DH1 5AN Durham
    County Durham
    EnglandBritishCompany Director1814360004
    FORREST, Howard, Doctor
    White Gates Cottage
    Elvaston Park Road
    NE46 2HT Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    White Gates Cottage
    Elvaston Park Road
    NE46 2HT Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishManaging Director59367130003
    HUDSON, Nigel Gary
    47 Reid Park Road
    Jesmond
    NE2 2ER Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    47 Reid Park Road
    Jesmond
    NE2 2ER Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishSoftware Supplier79380180002
    LAVERY, Kevin Gregory
    Old Colony House
    6, South King Street
    M2 6DQ Manchester
    Amministratore
    Old Colony House
    6, South King Street
    M2 6DQ Manchester
    United KingdomBritishChief Executive Newcastle City115961810003
    LUCAS, Irene
    Whitburn House
    47 Front Street
    SR6 7JG Whitburn
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Whitburn House
    47 Front Street
    SR6 7JG Whitburn
    Tyne & Wear
    BritishChief Executive84624570002
    ROBINSON, Jane
    29 Falcon Terrace
    NE41 8EE Wylam
    Northumberland
    Amministratore
    29 Falcon Terrace
    NE41 8EE Wylam
    Northumberland
    BritishArts Manager73016100001
    SCULLION, Wilfred Alexander
    Kepier Cottage
    Church Street
    DH4 4DN Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Kepier Cottage
    Church Street
    DH4 4DN Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    EnglandBritishElectrical Contractor71543190001
    SIMMS, David
    4 Hepscott Manor Farm
    NE61 6PH Hepscott
    Northumberland
    Amministratore
    4 Hepscott Manor Farm
    NE61 6PH Hepscott
    Northumberland
    United KingdomBritishSales Director Newspapers122464360001
    SINCLAIR, Patricia Frances
    Langley House Old Penshaw
    DH4 7EW Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Langley House Old Penshaw
    DH4 7EW Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    EnglandBritishAcademy Manager48648470001
    SUTHERLAND, Malcolm David
    Rickleton Lodge
    Bonemill Lane Rickleton
    NE38 9HB Washington
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Rickleton Lodge
    Bonemill Lane Rickleton
    NE38 9HB Washington
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector11841030001
    WATTS, Simon Paul
    Bridgeburn Lodge
    Ridley Mill Road
    NE43 7QU Stocksfield
    Northumberland
    Amministratore
    Bridgeburn Lodge
    Ridley Mill Road
    NE43 7QU Stocksfield
    Northumberland
    BritishSolicitor84950450001
    WITHERS, John Granville
    36 Fern Avenue
    Jesmond
    NE2 2QX Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    36 Fern Avenue
    Jesmond
    NE2 2QX Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishCompany Director43649100001
    WRIGHT, David Alexander
    19 Clifton Grove
    NE25 9UB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    19 Clifton Grove
    NE25 9UB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishExecutive Director73419600001
    WARD HADAWAY INCORPORATIONS LIMITED
    Sandgate House
    102 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore delegato nominato
    Sandgate House
    102 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    900020000001

    SANDCO 1158 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 23 nov 2001
    Consegnato il 12 dic 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Trade and Industry Acting Through the Small Business Service
    Transazioni
    • 12 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0