HILLARYS HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | HILLARYS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04178425 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova HILLARYS HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Unit 2 Churchill Park Private Road No 2 Colwick NG4 2JR Nottingham Nottinghamshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HILLGATE (223) LIMITED | 13 mar 2001 | 13 mar 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per HILLARYS HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 041784250006 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Darren Hansel Lock come amministratore in data 20 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2017 al 31 dic 2017 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 40 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 02 ott 2015 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 26 set 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Richard Thomas il 03 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Andrew Dalby come amministratore in data 28 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 041784250006, creata il 01 ago 2014 | 71 pagine | MR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWIS, David Mathew Aubrey | Amministratore | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire | United Kingdom | Australian | Business Executive | 110226830001 | ||||
RISMAN, John Matthew | Amministratore | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire | United Kingdom | British | Ceo | 107350020002 | ||||
THOMAS, Andrew Richard | Amministratore | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire England | United Kingdom | British | Business Executive | 154618250003 | ||||
DOBSON, Kevin Michael | Segretario | Highways 3 Grantham Road Radcliffe On Trent NG12 2HB Nottingham | British | Business Executive | 95476170001 | |||||
NICHOLSON, James Brett | Segretario | Laurel House 351 Mapperly Plains NG3 5RS Nottingham Nottinghamshire | British | Director | 99628210001 | |||||
HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 | |||||||
BURKE, David Richard Andrew | Amministratore | 4 Adams Court DE7 8YF Ilkeston Derbyshire | British | Director | 61576180002 | |||||
DALBY, Simon Andrew | Amministratore | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Business Executive | 110227460002 | ||||
DOBSON, Kevin Michael | Amministratore | Highways 3 Grantham Road Radcliffe On Trent NG12 2HB Nottingham | United Kingdom | British | Business Executive | 95476170001 | ||||
FERGUSON, Fiona Claire | Amministratore | Cleveland Cottage Main Street NG23 5BA Claypole Nottinghamshire | British | Director | 55116100001 | |||||
HOLMES, Roger Anthony | Amministratore | 421 Flagstaff House 10 St George Wharf SW8 2LZ Vauxhall London | United Kingdom | British | Business Executive | 105159350001 | ||||
LOCK, Darren Hansel | Amministratore | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Hillarys Blinds Limited Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 131597650005 | ||||
NICHOLSON, James Brett | Amministratore | Laurel House 351 Mapperly Plains NG3 5RS Nottingham Nottinghamshire | British | Director | 99628210001 | |||||
PETROW, Steven | Amministratore | Flat 2 48 Lennox Gardens SW1X 0DJ London | United Kingdom | American | Director | 96100200001 | ||||
RUSSO, Lorenzo | Amministratore | Flat 19 17 Eccleston Place SW1W 9NF London | Italian | Director | 96100220001 | |||||
SHANKS, Michael Anthony | Amministratore | Oakdene Main Street NG25 0UT Morton Nottinghamshire | British | Director | 25653690004 | |||||
SNAPES, Michael Joseph | Amministratore | Low Hill Cottage Low Hill Road, Roydon CM19 5JN Harlow Essex | British | Director | 64079340001 | |||||
WILDIG, Simon Roger | Amministratore | 21e Rydens Road KT12 3AB Walton On Thames Surrey | British | Director | 75978900001 | |||||
HILLGATE NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018840001 | |||||||
HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Amministratore delegato nominato | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillarys Blinds (Holdings) Limited | 30 giu 2016 | Private Road 2 Colwick Industrial Estate NG4 2JR Nottingham Unit 2 Churchill Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
HILLARYS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 01 ago 2014 Consegnato il 04 ago 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 21 giu 2007 Consegnato il 02 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the group to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A security agreement | Creato il 30 lug 2004 Consegnato il 13 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the principal debtor to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined) | Creato il 08 mag 2001 Consegnato il 22 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the lender under the terms of any finance document (all terms as defined) | |
Brevi particolari All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined) | Creato il 08 mag 2001 Consegnato il 22 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the security trustee under the terms of any finance document (all terms as defined) | |
Brevi particolari All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 mag 2001 Consegnato il 21 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party under or pursuant to any of the financing documents (including in particular under the guarantee). All terms as defined. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0