HILLARYS HOLDINGS LIMITED

HILLARYS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHILLARYS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04178425
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 2 Churchill Park
    Private Road No 2 Colwick
    NG4 2JR Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HILLGATE (223) LIMITED13 mar 200113 mar 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    1 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 041784250006 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Darren Hansel Lock come amministratore in data 20 feb 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2017 al 31 dic 2017

    3 pagineAA01

    Risoluzioni

    Resolutions
    40 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    1 pagineAA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 02 ott 2015

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 feb 2016

    Stato del capitale al 23 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 26 set 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 feb 2015

    Stato del capitale al 17 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Richard Thomas il 03 feb 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Simon Andrew Dalby come amministratore in data 28 nov 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 041784250006, creata il 01 ago 2014

    71 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEWIS, David Mathew Aubrey
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United KingdomAustralianBusiness Executive110226830001
    RISMAN, John Matthew
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishCeo107350020002
    THOMAS, Andrew Richard
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritishBusiness Executive154618250003
    DOBSON, Kevin Michael
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    Segretario
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    BritishBusiness Executive95476170001
    NICHOLSON, James Brett
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector99628210001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Segretario nominato
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001
    BURKE, David Richard Andrew
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    Amministratore
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    BritishDirector61576180002
    DALBY, Simon Andrew
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishBusiness Executive110227460002
    DOBSON, Kevin Michael
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    Amministratore
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    United KingdomBritishBusiness Executive95476170001
    FERGUSON, Fiona Claire
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    BritishDirector55116100001
    HOLMES, Roger Anthony
    421 Flagstaff House
    10 St George Wharf
    SW8 2LZ Vauxhall London
    Amministratore
    421 Flagstaff House
    10 St George Wharf
    SW8 2LZ Vauxhall London
    United KingdomBritishBusiness Executive105159350001
    LOCK, Darren Hansel
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director131597650005
    NICHOLSON, James Brett
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector99628210001
    PETROW, Steven
    Flat 2
    48 Lennox Gardens
    SW1X 0DJ London
    Amministratore
    Flat 2
    48 Lennox Gardens
    SW1X 0DJ London
    United KingdomAmericanDirector96100200001
    RUSSO, Lorenzo
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    Amministratore
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    ItalianDirector96100220001
    SHANKS, Michael Anthony
    Oakdene
    Main Street
    NG25 0UT Morton
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Oakdene
    Main Street
    NG25 0UT Morton
    Nottinghamshire
    BritishDirector25653690004
    SNAPES, Michael Joseph
    Low Hill Cottage
    Low Hill Road, Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    Amministratore
    Low Hill Cottage
    Low Hill Road, Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    BritishDirector64079340001
    WILDIG, Simon Roger
    21e Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    21e Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    BritishDirector75978900001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Amministratore delegato nominato
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018840001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Amministratore delegato nominato
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Unit 2 Churchill Park
    England
    30 giu 2016
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Unit 2 Churchill Park
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione262951
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HILLARYS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2014
    Consegnato il 04 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Management Limited
    Transazioni
    • 04 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 nov 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 21 giu 2007
    Consegnato il 02 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch as Agent and Trustee for the Secured Creditors (Security Agent)
    Transazioni
    • 02 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 30 lug 2004
    Consegnato il 13 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal debtor to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined)
    Creato il 08 mag 2001
    Consegnato il 22 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the lender under the terms of any finance document (all terms as defined)
    Brevi particolari
    All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Investment Partners Limited (The "Security Trustee") as the Generalpartner of Close Brothers Private Equity (UK) Fund Vi (the "Lender")
    Transazioni
    • 22 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined)
    Creato il 08 mag 2001
    Consegnato il 22 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the security trustee under the terms of any finance document (all terms as defined)
    Brevi particolari
    All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Equity (UK) Fund Vi Acting by Its General Partner Closeinvestment Partners Limited (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 22 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mag 2001
    Consegnato il 21 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under or pursuant to any of the financing documents (including in particular under the guarantee). All terms as defined.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee") Acting as Securitytrustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 21 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0