2E2 NETWORKS LIMITED

2E2 NETWORKS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società2E2 NETWORKS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04179263
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 2E2 NETWORKS LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova 2E2 NETWORKS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Mansion House, Benham
    Valence, Newbury
    RG20 8LU Berks
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 2E2 NETWORKS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KCC NETWORKS LIMITED14 mar 200114 mar 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di 2E2 NETWORKS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per 2E2 NETWORKS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2012

    Stato del capitale al 14 mar 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Stevens Mcveigh il 12 gen 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Stevens Mcveigh il 08 gen 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Paul Grossman il 08 gen 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Nicholas Paul Grossman il 08 gen 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin Fraser Henderson il 14 mar 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Terence William Burt il 22 feb 2011

    2 pagineCH01

    legacy

    38 pagineMG01

    legacy

    10 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    11 pagineAA

    legacy

    9 pagineMG01

    Nomina di Mr Kevin Fraser Henderson come amministratore

    1 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreement 25/04/2010
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    15 pagineAA

    legacy

    27 pagine395

    Chi sono gli amministratori di 2E2 NETWORKS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GROSSMAN, Nicholas Paul
    The Mansion House, Benham
    Valence, Newbury
    RG20 8LU Berks
    Segretario
    The Mansion House, Benham
    Valence, Newbury
    RG20 8LU Berks
    British157544150001
    BURT, Terence William
    One Wycombe Square
    W8 7JF London
    Flat 25
    United Kingdom
    Amministratore
    One Wycombe Square
    W8 7JF London
    Flat 25
    United Kingdom
    United KingdomBritish73890540004
    GROSSMAN, Nicholas Paul
    The Mansion House, Benham
    Valence, Newbury
    RG20 8LU Berks
    Amministratore
    The Mansion House, Benham
    Valence, Newbury
    RG20 8LU Berks
    New ZealandBritish157544150002
    HENDERSON, Kevin Fraser
    Scrivens Mead
    RG19 4FQ Thatcham
    5
    Berkshire
    Amministratore
    Scrivens Mead
    RG19 4FQ Thatcham
    5
    Berkshire
    EnglandBritish75091580001
    MCVEIGH, Mark Stevens
    The Mansion House, Benham
    Valence, Newbury
    RG20 8LU Berks
    Amministratore
    The Mansion House, Benham
    Valence, Newbury
    RG20 8LU Berks
    United KingdomBritish86272640004
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MCCORMACK, Penny
    Old School House
    School Lane
    RH14 9QL Billingshurst
    West Sussex
    Segretario
    Old School House
    School Lane
    RH14 9QL Billingshurst
    West Sussex
    British75091560001
    HENDERSON, Kevin Fraser
    5 Scrivens Mead
    RG19 4FQ Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    5 Scrivens Mead
    RG19 4FQ Thatcham
    Berkshire
    EnglandBritish75091580001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    2E2 NETWORKS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A confirmatory debenture
    Creato il 02 feb 2011
    Consegnato il 14 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Europe Limited (The Security Agent)
    Transazioni
    • 14 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 14 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hutton Collins Capital Partners Iii
    Transazioni
    • 14 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 21 giu 2010
    Consegnato il 03 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hutton Collins Capital Partners Iii
    Transazioni
    • 03 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 10 ott 2008
    Consegnato il 21 ott 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Europe Limited as Agent and Trustee for the Secured Creditors (Security Agent)
    Transazioni
    • 21 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 set 2006
    Consegnato il 04 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company or other obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and for Eachof the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 04 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 21 apr 2004
    Consegnato il 29 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from 2ESCAPE2 holdings limited and the subsidiaries to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gresham LLP as Trustee for Itself and the Registered Holders from Time to Time of Notes Issuedunder the Loan Note Instruments (In Such Capacity Trustee)
    Transazioni
    • 29 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 2003
    Consegnato il 06 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 15 lug 2003
    Consegnato il 26 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the subsidiaries to the chargee and the holders from time to time of the notes under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gresham LLP (Trustee)
    Transazioni
    • 26 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0