PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04179465 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Ms Diane Cougill come amministratore in data 13 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Antonios Erotocritou come amministratore in data 13 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Nomina di Dean Clarke come segretario in data 11 dic 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 11 dic 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 03 ago 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 03 ago 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Antonios Erotocritou come amministratore in data 02 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Stephen Mugge come amministratore in data 02 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Christopher Ross come amministratore in data 20 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 20 dic 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jennifer Owens come segretario in data 01 mar 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Stephen Mugge il 25 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARKE, Dean | Segretario | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 253940120001 | |||||||
COUGILL, Diane | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Chief Finance Officer | 158614590002 | ||||
ROSS, David Christopher | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | Irish | Director | 222326970001 | ||||
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Segretario | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 169016560001 | |||||||
EVANS, Paul William John | Segretario | 2 Stokes Hall Avenue Leyland PR25 3FA Preston Lancashire | British | Accountant | 44044870002 | |||||
GIFFORD, Nicola | Segretario | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 147967520001 | |||||||
GOURIET, Geoffrey Costerton | Segretario | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 249087400001 | |||||||
GREGORY, Jacqueline Anne | Segretario | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 221912790001 | |||||||
JOHNSTON, Graham Hamilton | Segretario | 13 Glencairn Park Road GL50 2ND Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 120581050001 | |||||
OWENS, Jennifer | Segretario | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | 183285330001 | |||||||
POWELL, Vernon David | Segretario | 18 Sunnybank Road Helmshore BB4 4PF Rossendale Lancashire | British | 65823910002 | ||||||
FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Segretario nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
BOULGER, Graham | Amministratore | 2 Church Gardens Euxton PR7 6LF Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Sales Director | 85225620001 | ||||
COTTRELL, Lee Michael | Amministratore | 6 Old School Drive Longton PR4 5YU Preston Lancashire | British | It Systems Developer | 86782930002 | |||||
COTTRELL, Patricia | Amministratore | 4 Longshaw Close Rufford L40 1XD Ormskirk Lancashire | British | Managing Director | 10934240003 | |||||
CULLUM, Peter Geoffrey | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Director | 59873490009 | ||||
DIXON, Richard John | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | Chief Operating Officer | 109138230001 | ||||
EGAN, Scott | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Director | 169209310001 | ||||
EROTOCRITOU, Antonios | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | Cypriot | Deputy Cfo | 167795710001 | ||||
EVANS, Paul William John | Amministratore | 2 Stokes Hall Avenue Leyland PR25 3FA Preston Lancashire | British | Accountant | 44044870002 | |||||
GALJAARD, Neil Edward | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Director | 99083340001 | ||||
HODGES, Mark Steven | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Director | 58444370003 | ||||
JOHNSON, Timothy David | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | Director | 140206600001 | ||||
JOHNSTON, Graham Hamilton | Amministratore | 13 Glencairn Park Road GL50 2ND Cheltenham Gloucestershire | England | British | Compliance Director | 120581050001 | ||||
MACIVER, Kenneth | Amministratore | The Poplars The Green TN12 8JS Horsmonden Kent | British | Company Director | 70920700002 | |||||
MUGGE, Mark Stephen | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | England | British | Director | 162920630005 | ||||
PATRICK, Ian William James | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | Director | 75028400004 | ||||
PENDER, Stuart Macpherson | Amministratore | Paymentshield House Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Merseyside | Scotland | British | Actuary | 284879040001 | ||||
POWELL, Vernon David | Amministratore | 18 Sunnybank Road Helmshore BB4 4PF Rossendale Lancashire | England | British | Accountant | 65823910002 | ||||
RIDING, Gareth James | Amministratore | 20 Springwood Drive Rufford L40 1XB Ormskirk Lancashire | England | British | Marketing Director | 73696810003 | ||||
RIDING, Michael Darren | Amministratore | 6 Cherry Orchard Longridge PR3 3PQ Preston Lancashire | British | Operations Director | 72100570008 | |||||
RIDING, Richard | Amministratore | 7 Longshaw Close Rufford L40 1XD Ormskirk Lancashire | British | Chairman | 25438550004 | |||||
STONE, Ann Marie | Amministratore | 7 Lismore Park Waterloo Road Birkdale PR8 2FY Southport Merseyside | British | Compliance Director | 98890470001 | |||||
TRAYNOR, Christopher | Amministratore | Burnside Gate ML3 6NP Hamilton 4 Lanarkshire | United Kingdom | British | Director | 135054750001 | ||||
FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Amministratore delegato nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paymentshield Limited | 06 apr 2016 | Wight Moss Way PR8 4HQ Southport Paymentshield House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PAYMENTSHIELD LIFE UNDERWRITING SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of accession to a debenture dated 1 november 2006 and | Creato il 29 giu 2009 Consegnato il 13 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 apr 2009 Consegnato il 06 mag 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 10 dic 2007 Consegnato il 21 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 nov 2006 Consegnato il 14 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 nov 2006 Consegnato il 14 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 ago 2004 Consegnato il 25 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0