HDG2018 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHDG2018 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04180966
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HDG2018 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HDG2018 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HDG2018 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HALLMARK DEVELOPMENTS GROUP LIMITED18 nov 200818 nov 2008
    NEWPORT PROPERTIES LIMITED16 mar 200116 mar 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di HDG2018 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per HDG2018 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Norman Edward Ewen come amministratore in data 18 gen 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Norman Edward Ewen come segretario in data 18 gen 2022

    1 pagineTM02

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineLIQ14

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da The Barn Monument Offices Maldon Road Woodham Mortimer, Maldon Essex CM9 6SN a Jupiter House Warley Hill Business Park the Drive Brentwood Essex CM13 3BE in data 17 mag 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 11 mar 2021

    LRESEX

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 gen 2020

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Derek Everington il 01 lug 2020

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 gen 2019

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Hallmark Developments (Essex) Ltd come persona con controllo significativo il 04 apr 2018

    2 paginePSC02

    Notifica di Hallmark Developments (Essex) Limited come persona con controllo significativo il 04 apr 2018

    2 paginePSC02

    Cessazione di Norman Edward Ewen come persona con controllo significativo il 04 apr 2018

    1 paginePSC07

    Cessazione di Stephen Derek Everington come persona con controllo significativo il 04 apr 2018

    1 paginePSC07

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name15 ago 2018

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 15 ago 2018

    RES15

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Cessazione della carica di Barry Andrew Brown come amministratore in data 04 apr 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione di Barry Andrew Brown come persona con controllo significativo il 04 apr 2018

    1 paginePSC07

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 lug 2018 al 31 gen 2019

    1 pagineAA01

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 04 apr 2018

    • Capitale: GBP 200
    4 pagineSH06

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 lug 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di HDG2018 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EVERINGTON, Stephen Derek
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Amministratore
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    EnglandBritish89416910007
    EWEN, Norman Edward
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Segretario
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    British28027870003
    GILBERT, Paul William
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    Segretario
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    British10393450001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BROWN, Barry Andrew
    17 Park Rise
    AL5 3AP Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Park Rise
    AL5 3AP Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish81596280001
    EWEN, Norman Edward
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Amministratore
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    EnglandBritish28027870003
    GILBERT, Paul William
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    Amministratore
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    EnglandBritish10393450001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HDG2018 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hallmark Developments (Essex) Limited
    Maldon Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn, Monument Offices
    Essex
    England
    04 apr 2018
    Maldon Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn, Monument Offices
    Essex
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Acts In England & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies Register In England & Wales
    Numero di registrazione04744551
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Hallmark Developments (Essex) Ltd
    The Barn, Monument Offices, Maldon Road,
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn
    Essex
    United Kingdom
    04 apr 2018
    The Barn, Monument Offices, Maldon Road,
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn
    Essex
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies In England & Wales
    Numero di registrazione04744551
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Stephen Derek Everington
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06 apr 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Norman Edward Ewen
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06 apr 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Barry Andrew Brown
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06 apr 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    HDG2018 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rental income from shop unit 3 roche close rochford.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rental income from shop unit 2 roche close rochford.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rental income from shop unit 1 roche close rochford.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rental income from unit 1 block b roche close rochford.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rental income from unit 2 block b roche close rochford.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rental income from unit 3 block b roche close rochford.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises shop unit 3 roche close rochford (also k/a 7 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises shop unit 2 roche close rochford (also k/a 6 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises shop unit 1 roche close rochford (also k/a 5 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises unit 1 block b roche close rochford (also k/a 3 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises unit 2 block b roche close rochford (also k/a 2 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creato il 12 lug 2010
    Consegnato il 15 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises unit 3 block b roche close rochford (aslo k/a 1 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 nov 2004
    Consegnato il 04 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 04 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 nov 2004
    Consegnato il 23 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at the rear of 3-7 heath drive gidea park romford essex t/n EGL446524.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 23 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HDG2018 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 mar 2021Inizio della liquidazione
    11 apr 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Glyn Mummery
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praticante
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Paul Atkinson
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praticante
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0