TECHDRILL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTECHDRILL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04190303
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TECHDRILL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TECHDRILL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Stonedale Road
    Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Gloucestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TECHDRILL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TECHDRILL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 apr 2016

    Stato del capitale al 14 apr 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Robbert Oudendijk come amministratore in data 30 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Paul O'neil come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher Paul O'neil il 22 lug 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2015

    Stato del capitale al 07 apr 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 18 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduce redemption reserve to nil 17/12/2014
    RES13

    Indirizzo della sede legale modificato da Martin Street Audenshaw Manchester M34 5JA a Stonedale Road Oldends Lane Industrial Estate Stonehouse Gloucestershire GL10 3RQ in data 30 ott 2014

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 apr 2014

    Stato del capitale al 02 apr 2014

    • Capitale: GBP 15,200
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Alastair James Fleming il 07 nov 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher Paul O'neil il 07 nov 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    12 pagineAA

    Nomina di Alastair James Fleming come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Valentine come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alastair Fleming come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Alison May Sloan come segretario

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Varie

    Sect 519
    1 pagineMISC

    Chi sono gli amministratori di TECHDRILL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SLOAN, Alison May
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Segretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    180812090001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Amministratore
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritish180854890001
    OUDENDIJK, Robbert
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    Amministratore
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    NetherlandsDutch201609020001
    BEATTIE, Bryan Percy
    Telford Court
    Loansdean
    NE61 2DB Morpeth
    Unit 15
    Northumberland
    Segretario
    Telford Court
    Loansdean
    NE61 2DB Morpeth
    Unit 15
    Northumberland
    162520300001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Segretario
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    168079970001
    HICKEY, Patrick Julian
    92 Ditton Walk
    CB5 8QE Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    92 Ditton Walk
    CB5 8QE Cambridge
    Cambridgeshire
    British66736130001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Martin Street
    Audenshaw
    M34 5JA Manchester
    Segretario
    Martin Street
    Audenshaw
    M34 5JA Manchester
    British167510920001
    OLIVER, Christopher John
    House
    Ulgham Park Farm Ulgham
    NE61 3AL Morpeth
    The Farm
    Northumberland
    United Kingdom
    Segretario
    House
    Ulgham Park Farm Ulgham
    NE61 3AL Morpeth
    The Farm
    Northumberland
    United Kingdom
    British75333050003
    BEATTIE, Kenneth Brian
    Casa Carioca Apartado 1092
    Praia Do Carvoeiro
    Lagoa
    8400
    Portugal
    Amministratore
    Casa Carioca Apartado 1092
    Praia Do Carvoeiro
    Lagoa
    8400
    Portugal
    EnglandBritish88804210001
    CHRISTODOULOU, Anne Patricia
    55 Queen Street
    CB8 8EX Newmarket
    Suffolk
    Amministratore
    55 Queen Street
    CB8 8EX Newmarket
    Suffolk
    British57700230001
    HUNTLEY, Derek
    Billown Mansion House
    Ballasalla
    IM9 3DL Isle Of Man
    The Stables
    Amministratore
    Billown Mansion House
    Ballasalla
    IM9 3DL Isle Of Man
    The Stables
    United KingdomBritish136042210001
    MCCRETON, Paul Benedict George
    The Thatched Cottage
    Mitford
    NE61 3PX Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    The Thatched Cottage
    Mitford
    NE61 3PX Morpeth
    Northumberland
    EnglandBritish75333150004
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish162062160001
    OLIVER, Christopher John
    House
    Ulgham Park Farm Ulgham
    NE61 3AL Morpeth
    The Farm
    Northumberland
    Amministratore
    House
    Ulgham Park Farm Ulgham
    NE61 3AL Morpeth
    The Farm
    Northumberland
    United KingdomBritish75333050004
    VALENTINE, Steven Grenville
    Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    4
    United Kingdom
    EnglandBritish92773870002

    TECHDRILL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 13 ott 2009
    Consegnato il 17 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to us $ account designation no rbstech-usd-1 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2009
    Consegnato il 28 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 01 apr 2008
    Consegnato il 05 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Eurofactor (UK) LTD
    Transazioni
    • 05 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 16 mag 2006
    Consegnato il 25 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re techdrill limited business premium account, account number 80585092. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0