MM (ROCHDALE) LIMITED

MM (ROCHDALE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMM (ROCHDALE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04192475
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MM (ROCHDALE) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova MM (ROCHDALE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MM (ROCHDALE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINCO 1619 LIMITED02 apr 200102 apr 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di MM (ROCHDALE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MM (ROCHDALE) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MM (ROCHDALE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2015

    Stato del capitale al 15 apr 2015

    • Capitale: GBP 1,000,001
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Colin Anthony Houlihan come amministratore in data 11 set 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robin Garry Bridge come amministratore in data 12 set 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 set 2014 al 31 mar 2014

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 apr 2014

    Stato del capitale al 17 apr 2014

    • Capitale: GBP 1,000,001
    SH01

    Nomina di Mr Graham Pearson come amministratore

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    24 giu 2014The date of appointment and the business occupation were removed from the AP01 on 24/06/2014 as the information was factually inaccurate.

    Nomina di Mr Graham Pearson come segretario

    3 pagineAP03
    Note
    DataNota
    24 giu 2014The date of appointment was removed from the AP03 on 24/06/2014 as the information was factually inaccurate.

    Cessazione della carica di Steven Nobes come amministratore

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    24 giu 2014The date of termination was removed from the TM01 on 24/06/2014 as the information was factually inaccurate.

    Cessazione della carica di Steven Nobes come segretario

    2 pagineTM02
    Note
    DataNota
    15 mag 2014This document is a duplicate of form TM02 registered on 10/04/2014.

    Nomina di Mr Graham Pearson come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Steven Nobes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven Nobes come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Graham Pearson come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robin Garry Bridge il 08 apr 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di MM (ROCHDALE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PEARSON, Graham
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    Segretario
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    186930730001
    HOULIHAN, Colin Anthony
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    Amministratore
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    EnglandBritish191894430001
    PEARSON, Graham
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    Amministratore
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    United KingdomBritish95884040002
    HINKLEY, Anthony John
    23 Brockenhurst Drive
    Harwood
    BL2 4HP Bolton
    Lancashire
    Segretario
    23 Brockenhurst Drive
    Harwood
    BL2 4HP Bolton
    Lancashire
    British84786630001
    NIGHTINGALE, Barry Graham Kirk
    Ravenhurst The Lane
    Heaton
    BL1 5DJ Bolton
    Lancashire
    Segretario
    Ravenhurst The Lane
    Heaton
    BL1 5DJ Bolton
    Lancashire
    British80722790001
    NIGHTINGALE, Barry Graham Kirk
    Ravenhurst The Lane
    Heaton
    BL1 5DJ Bolton
    Lancashire
    Segretario
    Ravenhurst The Lane
    Heaton
    BL1 5DJ Bolton
    Lancashire
    British80722790001
    NOBES, Steven Robert
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    Segretario
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    British114259410001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BRIDGE, Robin Garry
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    Amministratore
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    EnglandBritish89176260001
    HINKLEY, Anthony John
    23 Brockenhurst Drive
    Harwood
    BL2 4HP Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    23 Brockenhurst Drive
    Harwood
    BL2 4HP Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritish84786630001
    NIGHTINGALE, Barry Graham Kirk
    Ravenhurst The Lane
    Heaton
    BL1 5DJ Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Ravenhurst The Lane
    Heaton
    BL1 5DJ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish80722790001
    NOBES, Steven Robert
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    Amministratore
    Nixon Street
    Rochdale
    OL11 3JW Lancashire
    United KingdomBritish114259410001
    YATES, John Richard
    86 Victoria Road
    WA15 9AB Hale
    Cheshire
    Amministratore
    86 Victoria Road
    WA15 9AB Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish97822910001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76332110001

    MM (ROCHDALE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 18 mag 2005
    Consegnato il 01 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Marland mill, nixon street, rochdale t/no GM506089. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 2005
    Consegnato il 27 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Marland mill nixon street rochdale t/no GM506089 fixed charge all fixtures and fittings all plant and machinery vehicles and computer equipment at the property all furniture furnishings equipment tools and other chattels. Fixed charge the goodwill all rents receivable form any lease and the proceeds of any insurance.
    Persone aventi diritto
    • Rbef Limited as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Finance Parties
    Transazioni
    • 27 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 mag 2005
    Consegnato il 27 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbef Limited as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Finance Parties
    Transazioni
    • 27 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 mag 2005
    Consegnato il 25 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge deed
    Creato il 12 set 2002
    Consegnato il 18 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property being marland mill nixon street rochdale greater manchester t/no GM506089 the goodwill, benefit of any shareholdings, present and future licences, consents, permissions and agreements, all warranties, guarantees and indemnities, contracts and agreements, contracts of insurance. By way of floating charge over all other property assets rights and equipment and all its undertakings.
    Persone aventi diritto
    • Carcraft of Rochdale Limited
    Transazioni
    • 18 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0