STREETBROADCAST LIMITED

STREETBROADCAST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTREETBROADCAST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04203930
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STREETBROADCAST LIMITED?

    • (7440) /

    Dove si trova STREETBROADCAST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STREETBROADCAST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STREETBROADCAST PLC23 apr 200123 apr 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di STREETBROADCAST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per STREETBROADCAST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 feb 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 ago 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 feb 2011

    5 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 24 ago 2009

    72 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B

    22 pagine2.16B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    14 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    56 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    61 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    13 pagine363s

    legacy

    13 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    22 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di STREETBROADCAST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROWE, David Nicholas
    86a Widney Road
    Bentley Heath
    B93 9BN Solihull
    West Midlands
    Segretario
    86a Widney Road
    Bentley Heath
    B93 9BN Solihull
    West Midlands
    BritishAccountant113539370003
    CROWE, David Nicholas
    86a Widney Road
    Bentley Heath
    B93 9BN Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    86a Widney Road
    Bentley Heath
    B93 9BN Solihull
    West Midlands
    BritishAccountant113539370003
    DUNN, Gordon Bruce
    111 Abingdon Road
    W8 6QU London
    Amministratore
    111 Abingdon Road
    W8 6QU London
    EnglandAmericanFund Manager88009380001
    LINDSELL, Noel Patrick
    33 Portway
    BA5 2BA Wells
    Somerset
    Amministratore
    33 Portway
    BA5 2BA Wells
    Somerset
    EnglandBritishDirector107961290001
    MILES, Teresa Ann
    17 South Lodge
    Circus Road
    NW8 9ES London
    Amministratore
    17 South Lodge
    Circus Road
    NW8 9ES London
    AmericanCorporate Finance90580710004
    WATSON, Michael David
    27 Highacre
    RH4 3BF Dorking
    Surrey
    Amministratore
    27 Highacre
    RH4 3BF Dorking
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director63440350001
    DONNELLY, Mark Stephen
    24 Southdean Gardens
    SW19 6NU London
    Segretario
    24 Southdean Gardens
    SW19 6NU London
    BritishFinance Director87779290001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Segretario
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    TEAL, Timothy William
    7 Maryland Way
    TW16 6HN Sunbury On Thames
    Middlesex
    Segretario
    7 Maryland Way
    TW16 6HN Sunbury On Thames
    Middlesex
    British85672320001
    BIRKETT LONG SECRETARIES LIMITED
    Essex House 42 Crouch Street
    CO3 3HH Colchester
    Essex
    Segretario
    Essex House 42 Crouch Street
    CO3 3HH Colchester
    Essex
    43314810001
    ARTHUR, Lee Robert
    22 Woodcote Avenue
    CV11 6DE Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    22 Woodcote Avenue
    CV11 6DE Nuneaton
    Warwickshire
    United KingdomBritishGeneral Manager67066940001
    BEGG, Simon
    22 Twisden Road
    NW5 1DN London
    Amministratore
    22 Twisden Road
    NW5 1DN London
    BritishFund Manager103673590001
    CAMMACK, David James
    15 Ann Beaumont Way
    Hadleigh
    IP7 6SA Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    15 Ann Beaumont Way
    Hadleigh
    IP7 6SA Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishSolicitor75562440001
    COWIE, Martin
    31 The Avenue
    Brondesbury Park
    NW6 7NR London
    Amministratore
    31 The Avenue
    Brondesbury Park
    NW6 7NR London
    BritishDirector85175570001
    DONNELLY, Mark Stephen
    24 Southdean Gardens
    SW19 6NU London
    Amministratore
    24 Southdean Gardens
    SW19 6NU London
    BritishChartered Accountant87779290001
    FRANKLIN, Tilly Anne
    1a Kemplay Road
    NW3 1TA London
    Amministratore
    1a Kemplay Road
    NW3 1TA London
    BritishDirector59857570003
    LINDSELL, Noel
    126 Linkfield Road
    TW7 6QJ Isleworth
    Middlesex
    Amministratore
    126 Linkfield Road
    TW7 6QJ Isleworth
    Middlesex
    BritishAdvertising88521200001
    PROVINE, Robert
    One Central Park West
    Apt30a
    10023 New York
    New York 10016
    Usa
    Amministratore
    One Central Park West
    Apt30a
    10023 New York
    New York 10016
    Usa
    AmericanCog74756590003
    PULLUM, Keith William Banner
    16 Widford House
    Colebrooke Row
    N1 8DD London
    Amministratore
    16 Widford House
    Colebrooke Row
    N1 8DD London
    BritishConsultant93630040001
    RUSSELL, Clive Samuel
    3 Bristol Mews Little Venice
    W9 2JF London
    Amministratore
    3 Bristol Mews Little Venice
    W9 2JF London
    BritishDirector34948540003
    SANDERSON, Leonard Milton
    Broadacre Stokesheath Road
    Fairoak Lane
    KT22 0PP Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Broadacre Stokesheath Road
    Fairoak Lane
    KT22 0PP Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritishBusiness Adviser35817950001
    TCHENGUIZ, Vincent Aziz
    3 Lees Place
    Mayfair
    W1K 6LH London
    Amministratore
    3 Lees Place
    Mayfair
    W1K 6LH London
    United KingdomBritishCompany Director71890500003
    TEAL, Timothy William
    7 Maryland Way
    TW16 6HN Sunbury On Thames
    Middlesex
    Amministratore
    7 Maryland Way
    TW16 6HN Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishManagement Consultant85672320001
    TYE, Martin
    Blakeney
    11 The Poynings Richings Park
    SL0 9EV Slough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Blakeney
    11 The Poynings Richings Park
    SL0 9EV Slough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishPrint Consultant44873230001
    WILLIAMS, Martyn Courtney Bailey
    9 Chadlington Road
    OX2 6SY Oxford
    Amministratore
    9 Chadlington Road
    OX2 6SY Oxford
    EnglandBritishDirector37614850003
    BIRKETT LONG SECRETARIES LIMITED
    Essex House 42 Crouch Street
    CO3 3HH Colchester
    Essex
    Amministratore
    Essex House 42 Crouch Street
    CO3 3HH Colchester
    Essex
    43314810001

    STREETBROADCAST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 lug 2007
    Consegnato il 12 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Trustees Limited
    Transazioni
    • 12 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 apr 2007
    Consegnato il 03 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fse Loan Management Limited
    Transazioni
    • 03 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 ott 2006
    Consegnato il 18 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of security deposit
    Creato il 25 set 2006
    Consegnato il 28 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £25,000.00 and interest accrued thereon.
    Persone aventi diritto
    • Ashbank Property Co. Limited
    Transazioni
    • 28 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 24 ago 2006
    Consegnato il 30 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    £11,147.80 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    £11,147.80 placed in a specifically designated dfeposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael North, Robert Ian Joseph Rae and William Thomas Sanders
    Transazioni
    • 30 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 31 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 31 ott 2005
    Consegnato il 11 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposited sum being £18,682.50. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mount Eden Land Limited
    Transazioni
    • 11 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 02 gen 2002
    Consegnato il 17 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re streetbroadcast PLC high interest business account no. 20537071. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    STREETBROADCAST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 feb 2009Inizio dell'amministrazione
    22 feb 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Geoffrey Wayne Bouchier
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul John Clark
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    2
    DataTipo
    22 feb 2010Inizio della liquidazione
    07 giu 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Geoffrey Wayne Bouchier
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul John Clark
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praticante
    Menzies Corporate Restructuring
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0