ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED

ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04204306
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOREX EUROPE (HOLDINGS) LIMITED16 mag 200116 mag 2001
    SPEED 8732 LIMITED24 apr 200124 apr 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2013 al 30 set 2013

    3 pagineAA01

    Cessazione della carica di Andrew Thomson come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2013

    Stato del capitale al 08 mag 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Nomina di David William Hart Gray come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Gareth Wilson come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    14 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Adrian Stevens come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    15 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2012 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrea Fiumicelli il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew James Edward Thomson il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Adrian Charles Stevens il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Gareth Antony Wilson il 12 set 2011

    2 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom* in data 18 ago 2011

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT* in data 05 ago 2011

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Mr Andrew James Edward Thomson come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177357700001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Segretario
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Segretario
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Segretario
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162047940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Amministratore
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Amministratore
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishDirector101025710001
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Amministratore
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1 PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1 PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Amministratore
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishDirector105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishFinance Director74738270002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ISOFT NETHERLANDS (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second ranking share pledge
    Creato il 03 dic 2010
    Consegnato il 14 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares and share rights, the first ranking deed. Future assets of the second ranking share charge see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of pledge of shares
    Creato il 30 dic 2009
    Consegnato il 15 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights means all rights dividends interest money or property bonus see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 15 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 30 dic 2009
    Consegnato il 13 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A third ranking deed of pledge of shares
    Creato il 29 ott 2008
    Consegnato il 13 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee in its capacity as creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares and share rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V. (The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Second ranking deed of pledge of shares
    Creato il 29 lug 2008
    Consegnato il 15 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its shares and share rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V. (The Security Agent)
    Transazioni
    • 15 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of pledge
    Creato il 27 nov 2007
    Consegnato il 17 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Shares and share rights including any dividend, interest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V. London Branch (The Security Agent)
    Transazioni
    • 17 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of accession
    Creato il 27 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 24 ago 2006
    Consegnato il 31 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental guarantee and debenture
    Creato il 25 giu 2004
    Consegnato il 01 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any other of the parent company's subsidiaries (together the group) to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property known as unit 2 firecrest court warrington t/no CH445922, l/h property known as upminster unit 16 essex, l/h property known as sarum gate basingstoke t/no HP208786. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed charge the rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, rights as tenant, book debts and other debts. Floating charge all undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A legal charge containing fixed and floating charges
    Creato il 21 lug 2003
    Consegnato il 06 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h property known as churchfields, stonesfield, witney OX8 8PQ t/no ON214941 and all that f/h property known as unit 2 (postal number 310) firecrest court, centre park, warrington, cheshire, t/no CH445922. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Securedparties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0