STADCO HOLDINGS LTD.
Panoramica
| Nome della società | STADCO HOLDINGS LTD. |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04215953 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STADCO HOLDINGS LTD.?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova STADCO HOLDINGS LTD.?
| Indirizzo della sede legale | International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STADCO HOLDINGS LTD.?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| OFFSHELF 282 LTD | 14 mag 2001 | 14 mag 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STADCO HOLDINGS LTD.?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per STADCO HOLDINGS LTD.?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 15 ott 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark John Smith il 18 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Paul Fisher il 18 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW a International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE in data 07 ott 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark John Smith come segretario in data 05 set 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Hayhurst come segretario in data 05 set 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Mark John Smith come amministratore in data 30 nov 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Paul Fisher come amministratore in data 30 nov 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gregory Ian Macleod come amministratore in data 30 ott 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Gordon Hussey come amministratore in data 30 nov 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL a Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW in data 29 dic 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 042159530006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di STADCO HOLDINGS LTD.?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Mark John | Segretario | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | 213570940001 | |||||||
| FISHER, Christopher Paul | Amministratore | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 183747270001 | |||||
| SMITH, Mark John | Amministratore | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 124719430001 | |||||
| HAYHURST, Michael | Segretario | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | British | 15201970002 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Segretario | Plas Onn Quinta Weston Rhyn SY10 7LW Oswestry Shropshire | British | 10529040001 | ||||||
| OTHERS INTERESTS LTD | Segretario | Churchill House 47 Regent Road ST1 3RQ Stoke On Trent Staffordshire | 103784950001 | |||||||
| COOK, Jonathan Charles | Amministratore | The Backs 38 South Parade, Harbury CV33 9JE Leamington Spa Warwickshire | British | 72559760001 | ||||||
| HUSSEY, David Gordon | Amministratore | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | England | British | 131639570002 | |||||
| HUSSEY, David Gordon | Amministratore | Callingwood Lane Tatenhill DE13 9SH Burton-On-Trent Callingwood Hall Staffordshire United Kingdom | British | 131639570001 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Amministratore | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | United Kingdom | British | 10529040001 | |||||
| MACLEOD, Gregory Ian | Amministratore | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | United Kingdom | Australian | 60518160005 | |||||
| MORGAN, Kelvin Brian | Amministratore | Manderley Ellesmere Road Harmer Hill SY4 3EE Shrewsbury Shropshire | England | British | 74818010001 | |||||
| MORGAN, Kelvin Brian | Amministratore | Manderley Ellesmere Road Harmer Hill SY4 3EE Shrewsbury Shropshire | England | British | 74818010001 | |||||
| MORRISS, Andrew Stuart | Amministratore | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | England | British | 11643310001 | |||||
| ROACHE, David John | Amministratore | Fallowfield Badgers Lane CV35 0BY Lower Tysoe Warwickshire | United Kingdom | British | 40953790002 | |||||
| STERNE, Dermot Desmond | Amministratore | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | Uk | British | 96569780001 | |||||
| SWORD, John David | Amministratore | Chivel OX7 5TR Chipping Norton Oxfordshire | England | British | 1600540001 | |||||
| WILLIS, David John | Amministratore | Damson Cottage Highfields SY4 5UN Wem Shropshire | British | 51085590002 | ||||||
| YOUENS, Michael Arthur | Amministratore | 14 Westwood Drive The Mount SY3 8YB Shrewsbury Shropshire | British | 36008490001 | ||||||
| OFFSHELF LTD | Amministratore | Churchill House 47 Regent Road ST1 3RQ Stoke On Trent Staffordshire | 42228870001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di STADCO HOLDINGS LTD.?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acertec Engineering Limited | 06 apr 2016 | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
STADCO HOLDINGS LTD. ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 29 ago 2013 Consegnato il 06 set 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 29 ago 2013 Consegnato il 04 set 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 nov 2005 Consegnato il 01 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 28 feb 2003 Consegnato il 06 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 feb 2003 Consegnato il 06 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Pledge of shares | Creato il 23 lug 2002 Consegnato il 07 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed to the target group debenture | Creato il 23 lug 2002 Consegnato il 07 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0