STADCO HOLDINGS LTD.

STADCO HOLDINGS LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTADCO HOLDINGS LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04215953
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STADCO HOLDINGS LTD.?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova STADCO HOLDINGS LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    International House Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STADCO HOLDINGS LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OFFSHELF 282 LTD14 mag 200114 mag 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di STADCO HOLDINGS LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per STADCO HOLDINGS LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 ott 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark John Smith il 18 apr 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Paul Fisher il 18 apr 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW a International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE in data 07 ott 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Mark John Smith come segretario in data 05 set 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael Hayhurst come segretario in data 05 set 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mag 2016

    Stato del capitale al 09 mag 2016

    • Capitale: GBP 19,155,439
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    20 pagineAA

    Nomina di Mr Mark John Smith come amministratore in data 30 nov 2015

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Christopher Paul Fisher come amministratore in data 30 nov 2015

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gregory Ian Macleod come amministratore in data 30 ott 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Gordon Hussey come amministratore in data 30 nov 2015

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL a Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW in data 29 dic 2015

    2 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 042159530006 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di STADCO HOLDINGS LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Segretario
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    213570940001
    FISHER, Christopher Paul
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Amministratore
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish183747270001
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Amministratore
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish124719430001
    HAYHURST, Michael
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Segretario
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    British15201970002
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    Segretario
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    British10529040001
    OTHERS INTERESTS LTD
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    103784950001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    British72559760001
    HUSSEY, David Gordon
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Amministratore
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    EnglandBritish131639570002
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    British131639570001
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Amministratore
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    United KingdomBritish10529040001
    MACLEOD, Gregory Ian
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Amministratore
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    United KingdomAustralian60518160005
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Amministratore
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    EnglandBritish11643310001
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    Amministratore
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritish40953790002
    STERNE, Dermot Desmond
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Amministratore
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    UkBritish96569780001
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish1600540001
    WILLIS, David John
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    Amministratore
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    British51085590002
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    British36008490001
    OFFSHELF LTD
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    42228870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di STADCO HOLDINGS LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    06 apr 2016
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione555532
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    STADCO HOLDINGS LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 ago 2013
    Consegnato il 06 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Board of the Pension Protection Fund
    Transazioni
    • 06 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 ago 2013
    Consegnato il 04 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 nov 2005
    Consegnato il 01 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC 'Security Trustee'
    Transazioni
    • 01 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 06 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 06 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge of shares
    Creato il 23 lug 2002
    Consegnato il 07 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Known as Chase Manhattan International Limited) or Theother Finance Parties
    Transazioni
    • 07 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to the target group debenture
    Creato il 23 lug 2002
    Consegnato il 07 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly K/a Chase Manhattan International Limited)
    Transazioni
    • 07 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0