LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04216823 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Gorse Stacks House George Street CH1 3EQ Chester United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| VENICE LEEDS PROPCO LIMITED | 04 ott 2006 | 04 ott 2006 |
| RBS HOTEL INVESTMENTS NO 4 LIMITED | 15 mag 2001 | 15 mag 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 09 apr 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 23 apr 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 09 apr 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Soddisfazione dell'onere 042168230008 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2024 | 30 pagine | AA | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2023 | 30 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Sophie Gautier il 22 mag 2024 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Bour il 22 mag 2024 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Bour il 31 ott 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 28 pagine | AA | ||
Iscrizione dell'ipoteca 042168230010, creata il 06 dic 2023 | 18 pagine | MR01 | ||
Modifica dei dettagli di Lagonda Leeds Holdco Limited come persona con controllo significativo il 03 lug 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da , C/O Kpmg Llp One St. Peters Square, Manchester, M2 3AE, England a Gorse Stacks House George Street Chester CH1 3EQ in data 03 lug 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 28 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Lagonda Leeds Holdco Limited come persona con controllo significativo il 03 ago 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Bour il 25 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Nomina di Sophie Gautier come amministratore in data 21 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Elsa Tobelem come amministratore in data 21 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020 | 25 pagine | AA | ||
legacy | 267 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Chi sono gli amministratori di LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUR, Patrick | Amministratore | Rue De Madrid F-75008 Paris 10 France | France | French | 248839690002 | |||||
| GAUTIER, Sophie | Amministratore | Rue De Madrid F-75008 Paris 10 France | France | French | 293952500001 | |||||
| BARTLETT, Paul Eugene | Segretario | 16 Oster Street AL3 5JL St Albans Hertfordshire | British | 54206450004 | ||||||
| BENNISON, Matthew Edward | Segretario | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | British | 165710050001 | ||||||
| CASTRO, Marcos | Segretario | 45 Briavels Court Downshill Road KT18 5HP Epsom Surrey | British | 109248350002 | ||||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Segretario | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | 185108770001 | ||||||
| GRAHAM, Annabel Susan | Segretario | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | 108637650001 | ||||||
| SIDOLI, Domenico | Segretario | Cloville Hall Ship Road CM2 8XA Chelmsford Essex | Italian | 64784640002 | ||||||
| THOMAS, Marina Louise | Segretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||
| AAIM SECRETARIAL SERVICES LTD | Segretario | Fifth Floor 55 King Street M2 4LQ Manchester Lancashire | 124056370001 | |||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| BENNISON, Matthew Edward | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | British | 108534390002 | |||||
| BENNISON, Matthew Edward | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | British | 108534390002 | |||||
| BOAG, Timothy John Donald | Amministratore | 78 Bushwood Road TW9 3BQ Richmond Surrey | British | 62111350002 | ||||||
| BURRELL, James Alexander | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | 192486560001 | |||||
| CARPENTER, Paul | Amministratore | Broadoak 4 Overhill Road CR8 2JD Purley Surrey | United Kingdom | British | 53756030002 | |||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Amministratore | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Amministratore | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Amministratore | Flat 25 Boss House Boss Street SE1 2PS London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||
| ELTON, James Robert | Amministratore | 27 Elsie Road SE22 8DX London | United Kingdom | British | 55689440001 | |||||
| GALLAGHER, Geraldine Josephine | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | England | Irish | 185108770001 | |||||
| GREENSHIELDS, John Fraser | Amministratore | Highfield House The Lane TN3 0RP Fordcombe Kent | British | 62806730003 | ||||||
| HOURICAN, John Patrick | Amministratore | 64 Alma Road AL1 3BL St. Albans Hertfordshire | Irish | 77547010001 | ||||||
| HUNTER, Gail Susan | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 156206540001 | |||||
| HUNTER, Gail Susan | Amministratore | Principal Hotels 11 Ripon Road HG1 2JA Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 98567690002 | |||||
| LE LAY, Gael Thierry | Amministratore | Avenue Kleber 75016 Paris 10 France | France | French | 261991600001 | |||||
| MOY, Neal St John | Amministratore | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | 98781970001 | ||||||
| ROBERTSON, Iain Leith Johnston | Amministratore | 14 March Pines EH4 3PF Edinburgh | British | 52225140001 | ||||||
| ROBSON, Jeremy Godfrey | Amministratore | The Crossways Corseley Road TN3 9RT Groombridge East Sussex | British | 98782450001 | ||||||
| TAGLIAFERRI, Mark Lee | Amministratore | Cadogan Gardens SW3 2RF London Flat 2 105 United Kingdom | England | British,American | 106792270001 | |||||
| TAGLIAFERRI, Mark Lee | Amministratore | Flat 2 105 Cadogan Gardens SW3 2RF London | England | British,American | 106792270001 | |||||
| TOBELEM, Elsa | Amministratore | 30 Avenue Kleber 75016 Paris Covivio Hotels France | France | French | 284873460001 | |||||
| TROY, Anthony Gerard | Amministratore | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 104500230001 | |||||
| TROY, Anthony Gerard | Amministratore | Fountains Bent Darley Road, Bristwith HG3 2PN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 104500230001 | |||||
| WHITBY, Peter James | Amministratore | Turner House Chalcot Square NW1 8YP London 36c | Uk | British | 76096790001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LAGONDA LEEDS PROPCO LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonda Leeds Holdco Limited | 25 lug 2018 | George Street CH1 3EQ Chester Gorse Stacks House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Principal Hayley Group Limited | 06 apr 2016 | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Rome Investco Ltd | 06 apr 2016 | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0