CAVANAGH GROUP LIMITED

CAVANAGH GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAVANAGH GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04220482
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAVANAGH GROUP LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova CAVANAGH GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAVANAGH GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (2574) LIMITED21 mag 200121 mag 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAVANAGH GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CAVANAGH GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CAVANAGH GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Crown Place London EC2A 4FT

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Crown Place London EC2A 4FT a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 01 ago 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 lug 2014

    LRESSP

    Cessazione della carica di Andrew Steven Fay come amministratore in data 08 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 21 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 mag 2014

    Stato del capitale al 28 mag 2014

    • Capitale: GBP .01
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 lug 2013

    21 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Steven Fay il 02 ott 2013

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 29 lug 2013

    • Capitale: GBP 0.01
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 21 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 lug 2012

    21 pagineAA

    Nomina di Mr Edward Becton Davis come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Jessica Abigail Smith il 20 giu 2012

    2 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 21 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Steven Fay il 02 mag 2012

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CAVANAGH GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Jessica Abigail
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Segretario
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    162368540001
    CLARKE, Gillian Marjorie
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish154546630001
    CURRY, Richard Ian
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish105013710002
    DAVIS, Edward Becton
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomAmerican167180370001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    HAVERLAND MILLARD, Neill
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    Segretario
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    British78246160002
    HENSON, Ian Robert
    Shawbury Lane
    Nr Shustoke
    B46 2RU North Warwickshire
    Oakside Shawbury Village
    Segretario
    Shawbury Lane
    Nr Shustoke
    B46 2RU North Warwickshire
    Oakside Shawbury Village
    British134091530001
    MILLARD, Neill Haverland
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    Segretario
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    British157323990001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Segretario
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    British71468530002
    SMYTH, Robert Franklin
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    Segretario
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    British26738380001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    CAMPBELL, John William Duffus
    11 Cramond Glebe Gardens
    EH4 6NZ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    11 Cramond Glebe Gardens
    EH4 6NZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish1075710001
    CHAMBERS, Paul Stuart
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish172496620001
    FAY, Andrew Steven
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish194736380001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    GILLESPIE, Charles
    11 Garrick Avenue
    Mearnskirk
    G77 5GF Newton Mearns
    Glasgow
    Amministratore
    11 Garrick Avenue
    Mearnskirk
    G77 5GF Newton Mearns
    Glasgow
    Uk/ScotlandBritish85654910001
    HAVERLAND MILLARD, Neill
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    Amministratore
    The Gables
    Dragons Lane
    RH13 8GD Shipley
    West Sussex
    British78246160002
    HENSON, Ian Robert
    Shawbury Lane
    Nr Shustoke
    B46 2RU North Warwickshire
    Oakside Shawbury Village
    Amministratore
    Shawbury Lane
    Nr Shustoke
    B46 2RU North Warwickshire
    Oakside Shawbury Village
    EnglandBritish134091530001
    HOGARTH, Paul Henry
    Withington Hall
    Holmes Chapel Road Lower Withington
    SK11 9DS Chelford
    Cheshire
    Amministratore
    Withington Hall
    Holmes Chapel Road Lower Withington
    SK11 9DS Chelford
    Cheshire
    British12524640003
    LAST, Richard
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Leys Farm
    Banbury Road Great Tew
    OX7 4DL Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish80537570001
    LILEY, Mark
    8 Camel Grove
    KT2 5GR Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    8 Camel Grove
    KT2 5GR Kingston Upon Thames
    Surrey
    British68176370001
    MENDEL, Steven Paul
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Crown Place
    EC2A 4FT London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish147059160001
    REDGROVE, Simon George
    Green Street Barn, Green Street
    Shipley
    RH13 8JP West Sussex
    Amministratore
    Green Street Barn, Green Street
    Shipley
    RH13 8JP West Sussex
    EnglandBritish94696490001
    SINNETT, Paul Martin
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    Amministratore
    Mill Croft Barn
    Water Stratford Road
    MK18 4PD Tingewick
    EnglandBritish71468530002
    SMYTH, Robert Franklin
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    Amministratore
    Tangier Road
    GU1 2DE Guildford
    3
    Surrey
    EnglandBritish26738380001
    TIMMINS, Kenneth Douglas
    93 Craiglockhart Road
    EH14 1EP Edinburgh
    Midlothlian
    Amministratore
    93 Craiglockhart Road
    EH14 1EP Edinburgh
    Midlothlian
    United KingdomBritish51800860002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    CAVANAGH GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Scottish shares pledge
    Creato il 27 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right, title and interest in and to the shares and all rights, money or property of an income nature accruing on or payable or receivable in respect of any of the shares whether by way of dividend, distribution, interest or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 mag 2005
    Consegnato il 26 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,151.94 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The company charges to the landlord with full title guarantee its interest in the deposit and a separate designated interest-bearing account;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Horizon Technology Group PLC
    Transazioni
    • 26 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Shares charge
    Creato il 19 dic 2003
    Consegnato il 06 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares representing at any time the entire issued share capital of ernst & young financial management limited all dividends interest and other distributions all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities at any time whether by way of rights bonus capitalisation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 ott 2003
    Consegnato il 29 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    CAVANAGH GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 lug 2014Inizio della liquidazione
    24 lug 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0