CAVANAGH GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CAVANAGH GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04220482 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CAVANAGH GROUP LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova CAVANAGH GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CAVANAGH GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BROOMCO (2574) LIMITED | 21 mag 2001 | 21 mag 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CAVANAGH GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 lug 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CAVANAGH GROUP LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per CAVANAGH GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | 4.71 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Crown Place London EC2A 4FT | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 10 Crown Place London EC2A 4FT a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 01 ago 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Steven Fay come amministratore in data 08 lug 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 lug 2013 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Steven Fay il 02 ott 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Stato del capitale al 29 lug 2013
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 lug 2012 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Edward Becton Davis come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Jessica Abigail Smith il 20 giu 2012 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Steven Fay il 02 mag 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CAVANAGH GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Jessica Abigail | Segretario | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | 162368540001 | |||||||
| CLARKE, Gillian Marjorie | Amministratore | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | England | British | 154546630001 | |||||
| CURRY, Richard Ian | Amministratore | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 105013710002 | |||||
| DAVIS, Edward Becton | Amministratore | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | American | 167180370001 | |||||
| GARDNER, Douglas Charles | Segretario | 27 Balcombe Road RH16 1NZ Haywards Heath West Sussex | British | 75225920001 | ||||||
| HAVERLAND MILLARD, Neill | Segretario | The Gables Dragons Lane RH13 8GD Shipley West Sussex | British | 78246160002 | ||||||
| HENSON, Ian Robert | Segretario | Shawbury Lane Nr Shustoke B46 2RU North Warwickshire Oakside Shawbury Village | British | 134091530001 | ||||||
| MILLARD, Neill Haverland | Segretario | The Gables Dragons Lane RH13 8GD Shipley West Sussex | British | 157323990001 | ||||||
| SINNETT, Paul Martin | Segretario | Mill Croft Barn Water Stratford Road MK18 4PD Tingewick | British | 71468530002 | ||||||
| SMYTH, Robert Franklin | Segretario | Tangier Road GU1 2DE Guildford 3 Surrey | British | 26738380001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| CAMPBELL, John William Duffus | Amministratore | 11 Cramond Glebe Gardens EH4 6NZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 1075710001 | |||||
| CHAMBERS, Paul Stuart | Amministratore | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 172496620001 | |||||
| FAY, Andrew Steven | Amministratore | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 194736380001 | |||||
| GARDNER, Douglas Charles | Amministratore | 27 Balcombe Road RH16 1NZ Haywards Heath West Sussex | British | 75225920001 | ||||||
| GILLESPIE, Charles | Amministratore | 11 Garrick Avenue Mearnskirk G77 5GF Newton Mearns Glasgow | Uk/Scotland | British | 85654910001 | |||||
| HAVERLAND MILLARD, Neill | Amministratore | The Gables Dragons Lane RH13 8GD Shipley West Sussex | British | 78246160002 | ||||||
| HENSON, Ian Robert | Amministratore | Shawbury Lane Nr Shustoke B46 2RU North Warwickshire Oakside Shawbury Village | England | British | 134091530001 | |||||
| HOGARTH, Paul Henry | Amministratore | Withington Hall Holmes Chapel Road Lower Withington SK11 9DS Chelford Cheshire | British | 12524640003 | ||||||
| LAST, Richard | Amministratore | The Leys Farm Banbury Road Great Tew OX7 4DL Chipping Norton Oxfordshire | United Kingdom | British | 80537570001 | |||||
| LILEY, Mark | Amministratore | 8 Camel Grove KT2 5GR Kingston Upon Thames Surrey | British | 68176370001 | ||||||
| MENDEL, Steven Paul | Amministratore | Crown Place EC2A 4FT London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 147059160001 | |||||
| REDGROVE, Simon George | Amministratore | Green Street Barn, Green Street Shipley RH13 8JP West Sussex | England | British | 94696490001 | |||||
| SINNETT, Paul Martin | Amministratore | Mill Croft Barn Water Stratford Road MK18 4PD Tingewick | England | British | 71468530002 | |||||
| SMYTH, Robert Franklin | Amministratore | Tangier Road GU1 2DE Guildford 3 Surrey | England | British | 26738380001 | |||||
| TIMMINS, Kenneth Douglas | Amministratore | 93 Craiglockhart Road EH14 1EP Edinburgh Midlothlian | United Kingdom | British | 51800860002 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
CAVANAGH GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Scottish shares pledge | Creato il 27 nov 2007 Consegnato il 11 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right, title and interest in and to the shares and all rights, money or property of an income nature accruing on or payable or receivable in respect of any of the shares whether by way of dividend, distribution, interest or otherwise. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 13 mag 2005 Consegnato il 26 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £50,151.94 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The company charges to the landlord with full title guarantee its interest in the deposit and a separate designated interest-bearing account;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Shares charge | Creato il 19 dic 2003 Consegnato il 06 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The shares representing at any time the entire issued share capital of ernst & young financial management limited all dividends interest and other distributions all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities at any time whether by way of rights bonus capitalisation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 ott 2003 Consegnato il 29 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CAVANAGH GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0