LA TASCA GROUP LIMITED

LA TASCA GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLA TASCA GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04220541
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LA TASCA GROUP LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova LA TASCA GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lower Ground Floor, Elsley House
    24/30 Great Titchfield Street
    W1W 8BF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LA TASCA GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE RESTAURANT PEOPLE GROUP LIMITED27 lug 200127 lug 2001
    DMWSL 339 LIMITED21 mag 200121 mag 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di LA TASCA GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 mag 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per LA TASCA GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di James Forrester Spragg come amministratore in data 31 mar 2021

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor, 163 Eversholt Street London NW1 1BU England a Lower Ground Floor, Elsley House 24/30 Great Titchfield Street London W1W 8BF in data 10 mar 2021

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 mag 2019

    2 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 042205410015, creata il 14 gen 2020

    24 pagineMR01

    Nomina di Mr Adrian Walker come amministratore in data 06 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Giles Matthew Oliver David come segretario in data 06 dic 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Giles Matthew Oliver David come amministratore in data 06 dic 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr James Forrester Spragg come amministratore in data 30 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Richards come amministratore in data 30 apr 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 mag 2018

    2 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 042205410014, creata il 15 ago 2018

    25 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 042205410013, creata il 15 ago 2018

    25 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 mag 2017

    2 pagineAA

    Notifica di La Tasca Holdings Limited come persona con controllo significativo il 21 mag 2017

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 06 mar 2018

    2 paginePSC09

    Cessazione della carica di Timothy John Doubleday come amministratore in data 21 giu 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Giles Matthew Oliver David come segretario in data 21 giu 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy John Doubleday come segretario in data 21 giu 2017

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di LA TASCA GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WALKER, Adrian Rowland
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish265227060001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor, 163
    England
    Segretario
    Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor, 163
    England
    237559790001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Segretario
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    201021490001
    EVANS, Martin John
    6 Bellcast Close
    Appleton
    WA4 5SA Warrington
    Cheshire
    Segretario
    6 Bellcast Close
    Appleton
    WA4 5SA Warrington
    Cheshire
    British52869850002
    POWELL, Matthew David
    33 Tagg Wood View
    Ramsbottom
    BL0 9XP Bury
    Lancashire
    Segretario
    33 Tagg Wood View
    Ramsbottom
    BL0 9XP Bury
    Lancashire
    British125692100001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    MAZARS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Bridge House,
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower
    United Kingdom
    Segretario
    Bridge House,
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione759664
    130398850001
    ABBEY, Adrian Mark
    The Stables
    Mill Lane Broom
    B50 4HS Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    The Stables
    Mill Lane Broom
    B50 4HS Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish78951280002
    ARMOUR, Malcolm Craig
    104 Trinity Road
    EH5 3JZ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    104 Trinity Road
    EH5 3JZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish70810590001
    BAKER, Suzanne Louise
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    Amministratore
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    EnglandBritish35409580006
    BARNES, Michael John
    28 Old Lane
    Bramhope
    LS16 9AZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    28 Old Lane
    Bramhope
    LS16 9AZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish11951630001
    BROWN, Aaron Maxwell
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    Amministratore
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    United KingdomBritish98928830002
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor, 163
    England
    Amministratore
    Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor, 163
    England
    EnglandBritish187907210001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    EDWARD, Ian
    17 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    Amministratore
    17 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    EnglandBritish90337160001
    EVANS, Martin John
    6 Bellcast Close
    Appleton
    WA4 5SA Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    6 Bellcast Close
    Appleton
    WA4 5SA Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish52869850002
    GRUNNELL, Mark
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    Amministratore
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    United KingdomBritish94144450002
    HAVENHAND, Jonathan
    20 Canterbury Avenue
    Fulwood
    S10 3RT Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    20 Canterbury Avenue
    Fulwood
    S10 3RT Sheffield
    Yorkshire
    British80812860002
    HORLER, James Michael Alexander
    West End Farm
    Main Street
    WR11 7UE Sedgeberrow
    Worcestershire
    Amministratore
    West End Farm
    Main Street
    WR11 7UE Sedgeberrow
    Worcestershire
    British65293140002
    KEEN, Christian
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    Amministratore
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    United KingdomBritish117424240001
    MCLAUGHLIN, Mary Catherine
    The Cobbles
    Donkey Lane
    SK9 1PX Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    The Cobbles
    Donkey Lane
    SK9 1PX Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomIrish58320700002
    MYERS, David Paul
    Glyme Court
    Oxford Office Village Off Langford Lane
    OX5 1LQ Kidlington
    County House
    Oxford
    United Kingdom
    Amministratore
    Glyme Court
    Oxford Office Village Off Langford Lane
    OX5 1LQ Kidlington
    County House
    Oxford
    United Kingdom
    EnglandBritish142171370001
    POWELL, Matthew David
    33 Tagg Wood View
    Ramsbottom
    BL0 9XP Bury
    Lancashire
    Amministratore
    33 Tagg Wood View
    Ramsbottom
    BL0 9XP Bury
    Lancashire
    EnglandBritish125692100001
    RICHARDS, Stephen
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish187618040002
    RICHARDSON, Richard William
    16 Pecketts Way
    HG1 3EW Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    16 Pecketts Way
    HG1 3EW Harrogate
    North Yorkshire
    British31914560002
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Amministratore
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002
    SPRAGG, James Forrester
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish127602840002
    SYMONDS, Paul
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish80167420001
    WETTON, Gavin
    Kingfisher Way
    Cottenham
    CB24 8XN Cambridge
    30
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Kingfisher Way
    Cottenham
    CB24 8XN Cambridge
    30
    Cambridgeshire
    EnglandBritish141080490001
    WILKINSON, Simon
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158424890001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Amministratore
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LA TASCA GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    21 mag 2017
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07505029
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per LA TASCA GROUP LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    21 mag 201721 mag 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    LA TASCA GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 gen 2020
    Consegnato il 16 gen 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 16 gen 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 ago 2018
    Consegnato il 23 ago 2018
    In corso
    Breve descrizione
    None at the date of the charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transazioni
    • 23 ago 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 ago 2018
    Consegnato il 23 ago 2018
    In corso
    Breve descrizione
    All current and future interests in property and intellectual property owned by the company, in each case as defined in the supplemental debenture registered by this form MR01. For more details please refer to the supplemental debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 23 ago 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 feb 2016
    Consegnato il 12 feb 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transazioni
    • 12 feb 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 25 set 2015
    Consegnato il 05 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 set 2015
    Consegnato il 02 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 02 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 feb 2011
    Consegnato il 28 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each obligor and bay restaurant holdings limited and la tasca, inc to the security trustee or to any of the other secured parties or any other finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank Ag Filiale Luxemburg
    Transazioni
    • 28 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 mar 2008
    Consegnato il 03 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent and each obligor of la tasca, inc to the chargee or to any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Bank Hf, Kaupthing Singer and Friedlander LTD, Dresdner Bank Ag London Branch, Simon Appell and Alastair Beveridge Each of Kroll Limited and Others
    Transazioni
    • 03 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 07 nov 2002
    Consegnato il 22 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations); and the assignor's whole right title and interest present and future in the policy. The policy of life assurance on the life of michael john barnes with scottish equitable PLC (policy number LO0191147322) dated 30 september 2002.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee") as Security Trusteefor Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 22 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 23 ago 2002
    Consegnato il 11 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy of life assurance on the life of james michael alexander horler with scottish equitable PLC (policy number LO199333112) dated 16TH november 2001 all sums assured by it and all bonuses and benefits accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 11 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 23 ago 2002
    Consegnato il 11 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy of life assurance on the life of jonathan havenhand with norwich union linked life assurance (policy number 7748495EG) dated 18TH june 2002 all sums assured by it and all bonuses and benefits accruing therefrom.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 11 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 23 ago 2002
    Consegnato il 11 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy of life assurance on the life of mary catherine mclaughlin with norwich union linked life assurance limited (policy number 7784177EL) dated 15TH april 2002 all sums assured by it and all bo. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 11 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 23 ago 2002
    Consegnato il 11 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy of life assurance on the life of martin john evans with norwich union linked life assurance limited (policy number 7784384EU) dated 5TH april 2002 and all bonuses and benefits accruing ther. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 11 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 13 feb 2002
    Consegnato il 16 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policy of life insurance on the life of michael john barnes with scottish equitable (policy number L0196780902), all sums assured by it and all bonuses and benefits wich may arise under it.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 set 2001
    Consegnato il 13 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties and to the holders of the secured consideration loan notes under the secured consideration loan notes (as defined therein) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0