GO INTEGRATED SERVICES LIMITED

GO INTEGRATED SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGO INTEGRATED SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04226788
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GO INTEGRATED SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GO INTEGRATED SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GO INTEGRATED SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HR GO INTEGRATED SERVICES LIMITED27 mar 200827 mar 2008
    JOBS4EUROPE LIMITED25 apr 200725 apr 2007
    EMPLOY EU LIMITED09 lug 200409 lug 2004
    PENNINE ENGINEERING LTD07 gen 200207 gen 2002
    PENNINE RECRUITMENT LTD13 dic 200113 dic 2001
    PARKINSON JV SEVENTY-TWO LIMITED01 giu 200101 giu 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di GO INTEGRATED SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GO INTEGRATED SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GO INTEGRATED SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Nomina di Mr John Matthew Parkinson come segretario in data 15 ago 2014

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr John Matthew Parkinson come amministratore in data 15 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Hugh Edward Billot come segretario in data 15 ago 2014

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Hugh Edward Billot come amministratore in data 15 ago 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 lug 2014

    Stato del capitale al 28 lug 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Nomina di Dr Hugh Edward Billot come segretario in data 26 feb 2013

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Andrew Kingston come segretario in data 26 feb 2013

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Mark Andrew Kingston il 01 ott 2011

    1 pagineCH03

    Nomina di Dr Hugh Edward Billot come amministratore in data 07 nov 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Robert Harvey come amministratore in data 07 nov 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Christopher Robert Harvey come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Parkinson come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GO INTEGRATED SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PARKINSON, John Matthew
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Segretario
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    191275770001
    PARKINSON, John Matthew
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Amministratore
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    EnglandBritishCompany Director149699140001
    BILLOT, Hugh Edward, Dr
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Segretario
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    179495800001
    KINGSTON, Mark Andrew
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Segretario
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    British129202050001
    PRIOR, Anthony Edward
    The Cedars
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    Kent
    Segretario
    The Cedars
    Church Road
    TN23 1RQ Ashford
    Kent
    British79649720001
    BILLOT, Hugh Edward, Dr
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    Amministratore
    Wellington House
    Church Road
    TN23 1RE Ashford
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director39608830001
    HARVEY, Christopher Robert
    Dunn Street Road
    ME7 3LX Bredhurst
    Forge Cottage
    Kent
    Amministratore
    Dunn Street Road
    ME7 3LX Bredhurst
    Forge Cottage
    Kent
    EnglandBritishCompany Director22869490002
    HURREN, David James
    54 Sittingbourne Road
    ME14 5HZ Maidstone
    Kent
    Amministratore
    54 Sittingbourne Road
    ME14 5HZ Maidstone
    Kent
    BritishCompany Director35114260004
    KLARIC, Tihomir
    The Post House
    High Street
    CT13 0HF Eastry
    Kent
    Amministratore
    The Post House
    High Street
    CT13 0HF Eastry
    Kent
    United KingdomSouth AfricanCompany Director150524040001
    MCCORMICK, David Joseph
    46 Thorn Grove
    Cheadle Hulme
    SK8 7LP Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    46 Thorn Grove
    Cheadle Hulme
    SK8 7LP Cheadle
    Cheshire
    BritishCompany Director63117500001
    MORRISON, Murdo Mckenzie
    Bumbles
    70 High Street
    CM17 0DR Old Harlow
    Essex
    Amministratore
    Bumbles
    70 High Street
    CM17 0DR Old Harlow
    Essex
    EnglandBritishCompany Director38342650004
    PARKINSON, John Charles
    Foley Farm Barn
    Leeds
    ME17 1RR Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Foley Farm Barn
    Leeds
    ME17 1RR Maidstone
    Kent
    EnglandBritishCompany Director100175830001
    STEVENSON, Mark Jonathan
    Bracken Edge
    Bossingham Road, Stelling Minnis
    CT4 6BD Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Bracken Edge
    Bossingham Road, Stelling Minnis
    CT4 6BD Canterbury
    Kent
    BritishCompany Director124857600001

    GO INTEGRATED SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed & floating charge
    Creato il 30 mag 2008
    Consegnato il 10 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 10 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 nov 2006
    Consegnato il 05 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited (The Financier)
    Transazioni
    • 05 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 21 set 2005
    Consegnato il 27 set 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0