CITY NET CATERING (UK) LIMITED

CITY NET CATERING (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCITY NET CATERING (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04232021
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CITY NET CATERING (UK) LIMITED?

    • Attività di ristorazione per eventi (56210) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova CITY NET CATERING (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    142-148 Main Road
    DA14 6NZ Sidcup
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CITY NET CATERING (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CITY NET CATERING LTD11 giu 200111 giu 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di CITY NET CATERING (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CITY NET CATERING (UK) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CITY NET CATERING (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da * Lsg Sky Chefs Heathrow Boulevard 2 284 Bath Road, Sipson West Drayton Middlesex UB7 0DQ United Kingdom* in data 23 dic 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 giu 2013

    Stato del capitale al 28 giu 2013

    • Capitale: GBP 17,917
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lutz Christoph Scharpe il 27 giu 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2011

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lutz Christoph Scharpe il 15 giu 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Muhammad Waqas il 15 giu 2012

    2 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da * 27 Central Way Feltham Middlesex TW14 0UU United Kingdom* in data 15 giu 2012

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lutz Christoph Scharpe il 15 feb 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 27 Central Way Feltham Middlesex TW14 0UU United Kingdom* in data 15 giu 2011

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Bollands Minerva Mill Station Road Alcester Warwickshire B49 5ET* in data 15 giu 2011

    1 pagineAD01

    Nomina di Muhammad Waqas come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Abbotts come segretario

    2 pagineTM02

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    22 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lutz Christoph Scharpe il 01 nov 2010

    3 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CITY NET CATERING (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WAQAS, Muhammad
    Heathrow Boulevard 2
    284 Bath Road, Sipson
    UB7 0DQ West Drayton
    Lsg Sky Chefs
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    Heathrow Boulevard 2
    284 Bath Road, Sipson
    UB7 0DQ West Drayton
    Lsg Sky Chefs
    Middlesex
    United Kingdom
    British159016440001
    SCHARPE, Lutz Christoph
    Main Road
    DA14 6NZ Sidcup
    142-148
    Kent
    Amministratore
    Main Road
    DA14 6NZ Sidcup
    142-148
    Kent
    United KingdomGermanVp Finance And It Europe155539150005
    ABBOTTS, Andrew John
    C/O Bollands Minerva Mill
    Station Road
    B49 5ET Alcester
    Warwickshire
    Segretario
    C/O Bollands Minerva Mill
    Station Road
    B49 5ET Alcester
    Warwickshire
    BritishUk Head Of Finance139049240001
    ALBON, Diana Bernadette
    4 Selworthy Road
    Castle Bromwich
    B36 0HP Birmingham
    Segretario
    4 Selworthy Road
    Castle Bromwich
    B36 0HP Birmingham
    BritishCompany Secretary115787130002
    HEWITT, Geoffrey Douglas
    23 Denise Drive
    Harborne
    B17 0BN Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    23 Denise Drive
    Harborne
    B17 0BN Birmingham
    West Midlands
    British51558170001
    MONIE, Lars Johan Yngve
    Skrallinge Gard
    74082 Orsundsebro
    Segretario
    Skrallinge Gard
    74082 Orsundsebro
    Swedish83406420001
    SAUNDERS, Richard John
    The Grindles
    Kings Coughton
    B49 5QD Alcester
    Warwickshire
    Segretario
    The Grindles
    Kings Coughton
    B49 5QD Alcester
    Warwickshire
    British102524500001
    SOVEREIGN DIRECTORS (T&C) LIMITED
    PO BOX 170 Front Street
    Churchill Building
    Grand Turk
    Turks &Caicos Islands
    Segretario
    PO BOX 170 Front Street
    Churchill Building
    Grand Turk
    Turks &Caicos Islands
    73138440001
    SOVEREIGN SECRETARIES LTD
    4th Floor Palladium House
    1-4 Argyll Street
    W1V 1AD London
    Segretario
    4th Floor Palladium House
    1-4 Argyll Street
    W1V 1AD London
    61184470001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CEDERKVIST, Mette
    Dk-2820 Gentofte
    Fuglegardsvaenget 52
    Denmark
    Amministratore
    Dk-2820 Gentofte
    Fuglegardsvaenget 52
    Denmark
    DanishVice President Finance130904240001
    EASDON, Dale
    C/O Bollands Minerva Mill
    Station Road
    B49 5ET Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    C/O Bollands Minerva Mill
    Station Road
    B49 5ET Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritishChief Operating Officer119032000002
    FROLEN, Bo Harald Wilhem
    Olaks Petrigatan 34
    FOREIGN 41270 Gothenburg
    Sweden
    Amministratore
    Olaks Petrigatan 34
    FOREIGN 41270 Gothenburg
    Sweden
    SwedishManaging Director77595170001
    JENKINSON, Annette
    C/O Bollands Minerva Mill
    Station Road
    B49 5ET Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    C/O Bollands Minerva Mill
    Station Road
    B49 5ET Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritishGeneral Manager For North130903990001
    MONIE, Johan
    25 William Close
    Stubbington
    PO14 2PQ Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    25 William Close
    Stubbington
    PO14 2PQ Fareham
    Hampshire
    United KingdomSwedishDirector87343590003
    MONIE, Lars Johan Yngve
    Skrallinge Gard
    740 82 Orsundsbro
    Froslunda
    Sweden
    Amministratore
    Skrallinge Gard
    740 82 Orsundsbro
    Froslunda
    Sweden
    SwedishManaging Director83406420002
    SAUNDERS, Richard John
    The Grindles
    Kings Coughton
    B49 5QD Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    The Grindles
    Kings Coughton
    B49 5QD Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritishCatering Manager102524500001
    WOODLEY, Ian George
    Nursery Cottage
    Burhill Road
    KT12 4BE Burhill
    Surrey
    Amministratore
    Nursery Cottage
    Burhill Road
    KT12 4BE Burhill
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director80415910001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SOVEREIGN DIRECTORS (T&C) LIMITED
    PO BOX 170 Front Street
    Churchill Building
    Grand Turk
    Turks &Caicos Islands
    Amministratore
    PO BOX 170 Front Street
    Churchill Building
    Grand Turk
    Turks &Caicos Islands
    73138440001
    SOVEREIGN SECRETARIES LTD
    4th Floor Palladium House
    1-4 Argyll Street
    W1V 1AD London
    Amministratore
    4th Floor Palladium House
    1-4 Argyll Street
    W1V 1AD London
    61184470001

    CITY NET CATERING (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 19 dic 2007
    Consegnato il 22 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 04232021 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 12 apr 2007
    Consegnato il 18 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £343.75 to be held in an interest earning deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dencora (Docklands) Limited
    Transazioni
    • 18 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 12 apr 2007
    Consegnato il 18 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £7,050 to be held in an interest earning deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Decora (Docklands) Limited
    Transazioni
    • 18 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge of deposit
    Creato il 22 ago 2006
    Consegnato il 05 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 10205943 at 161326 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge of deposit
    Creato il 24 mag 2006
    Consegnato il 06 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £40,000 credited to account designation 10205943 with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 28 feb 2006
    Consegnato il 03 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 03 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 13 feb 2004
    Consegnato il 20 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re city net catering (UK) limited and numbered 03090602 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 14 mar 2003
    Consegnato il 22 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First floating charge all the chargors undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Danske Bank a/S
    Transazioni
    • 22 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CITY NET CATERING (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 dic 2013Inizio della liquidazione
    28 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nedim Patrick Ailyan
    142/148 Main Road
    DA14 6NZ Sidcup
    Kent
    Praticante
    142/148 Main Road
    DA14 6NZ Sidcup
    Kent

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0