BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04232204 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED?
- Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Eynsham Hall North Leigh OX29 6PN Witney Oxfordshire United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SUNDRIDGE PARK MANAGEMENT CENTRE LIMITED | 11 giu 2001 | 11 giu 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Pannell House Park Street Guildford Surrey GU1 4HN United Kingdom a 2nd Floor 31 Chertsey Street Guildford Surrey GU1 4HD | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Pannell House Park Street Guildford Surrey GU1 4HN | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da St. Thomas's Church St. Thomas Street London SE1 9RY a Eynsham Hall North Leigh Witney Oxfordshire OX29 6PN in data 27 nov 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Michelle Elizabeth Young come segretario in data 02 nov 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Raymond Miller come segretario in data 02 nov 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Martin Alan Wood come amministratore in data 26 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di David Raymond Miller come segretario in data 21 ott 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Andrew O'reilly come segretario in data 21 ott 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Barry John Bennett come amministratore in data 30 giu 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 2Nd Floor 2 City Place Beehive Ring Road Gatwick West Sussex RH6 0PA United Kingdom a Pannell House Park Street Guildford Surrey GU1 4HN | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUNG, Michelle Elizabeth | Segretario | North Leigh OX29 6PN Witney Eynsham Hall Oxfordshire United Kingdom | 203067550001 | |||||||
| UPTON, Richard | Amministratore | North Leigh OX29 6PN Witney Eynsham Hall Oxfordshire United Kingdom | England | British | 204950320001 | |||||
| KELLY, Anthony Brian | Segretario | 1 Cricketers Close Ashington RH20 3JQ Pulborough West Sussex | British | 66203340002 | ||||||
| MILLER, David Raymond | Segretario | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | 193073210001 | |||||||
| MILLS, Ronald Charles | Segretario | 12 The Warren CM12 0LW Billericay Essex | British | 2836970002 | ||||||
| O'REILLY, John Andrew | Segretario | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | 160046340001 | |||||||
| RUDD, Andrew James | Segretario | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | British | 138471350001 | ||||||
| SCOTT, Christopher Richard | Segretario | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | British | 81998190003 | ||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Segretario nominato | Leonard Street EC2A 4QS London 83 | 900013740001 | |||||||
| ACKERMAN, Stephen Carl | Amministratore | The Cottage Shenfield Green CM15 8NG Shenfield Essex | England | British | 154539780001 | |||||
| BENNETT, Barry John | Amministratore | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | United Kingdom | Irish | 14707370002 | |||||
| BOTHWELL, Karen Margaret | Amministratore | 68 Ravelston Dykes EH12 6HF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 34800860003 | |||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Amministratore | Spruce Tree House By Gleneagles PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | 122926460001 | ||||||
| CULLINGFORD, David Edward | Amministratore | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | United Kingdom | British | 33796520003 | |||||
| CUMMINGS, Peter Joseph | Amministratore | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | 68241910003 | |||||
| DICKSON, Pamela Simone | Amministratore | 38 Belmont Gardens EH12 6JD Edinburgh | United Kingdom | Scottish | 91810830001 | |||||
| EYLES, Peter George | Amministratore | Cross Oak House Cross Oak Lane RH1 5RF Redhill Surrey | United Kingdom | British | 98648030001 | |||||
| ISAACS, Paul Samuel | Amministratore | Rosemead Woodhill Road CM3 4DY Danbury Essex | England | British | 141827450001 | |||||
| KELLY, Anthony Brian | Amministratore | 1 Cricketers Close Ashington RH20 3JQ Pulborough West Sussex | British | 66203340002 | ||||||
| MILLS, Ronald Charles | Amministratore | 12 The Warren CM12 0LW Billericay Essex | United Kingdom | British | 2836970002 | |||||
| SCOTT, Christopher Richard | Amministratore | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | England | British | 81998190003 | |||||
| WOOD, Martin Alan | Amministratore | St. Thomas's Church St. Thomas Street SE1 9RY London | United Kingdom | British | 149906140001 | |||||
| LUCIENE JAMES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003210001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley Town Hall Limited | 14 set 2016 | North Leigh OX29 6PN Witney Eynsham Hall Oxfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BROMLEY TOWN HALL MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 19 gen 2005 Consegnato il 28 gen 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Legal mortgage all estates or interest in the f/h l/h hanover international conference and training centre plaistow lane bromley t/n SGL539181 and the lodge 67 plaistow lane bromley t/n SGL622848 together with all buildings fixtures plant and machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 17 lug 2001 Consegnato il 31 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations of each obligor to the security trustee and the secured parties | |
Brevi particolari The f/h property k/a the butten building and the mansion house and land at sunbridge park, bromley, kent t/n SGL539181, the f/h property k/a the lodge, 67 plaisow lane, bromley t/n SGL622848. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0