INGLEBY SUB LIMITED

INGLEBY SUB LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINGLEBY SUB LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04240184
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INGLEBY SUB LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova INGLEBY SUB LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Highfield Court Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INGLEBY SUB LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROAD ANGEL GROUP LIMITED28 set 200628 set 2006
    BLACK SPOT INTERACTIVE LIMITED13 set 200113 set 2001
    EGGSHELL (467) LIMITED25 giu 200125 giu 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di INGLEBY SUB LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per INGLEBY SUB LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    21 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Pritchard Williams come amministratore in data 28 giu 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Stefan Leon Borson come amministratore in data 07 nov 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Edward Ian Charles Walker come segretario in data 07 nov 2018

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name28 mar 2018

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 mar 2018

    RES15

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS England a Highfield Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh SO53 3TY in data 13 feb 2018

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2017 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Ingleby (1653) Limited come persona con controllo significativo il 04 giu 2016

    2 paginePSC02

    Indirizzo della sede legale modificato da Clark House Silverstone Technology Park Silverstone Circuit Silverstone Northamptonshire NN12 8GX a 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS in data 09 gen 2017

    1 pagineAD01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    25 pagineAA

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 25 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2016

    Stato del capitale al 01 lug 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Mr Edward Ian Charles Walker come segretario in data 31 mag 2016

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di INGLEBY SUB LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BORSON, Stefan Leon
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    England
    Amministratore
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    England
    EnglandBritish117811010002
    EAGLE, Anthony Joseph
    6 Adelaide Crescent
    BN3 2JE Hove
    East Sussex
    Segretario
    6 Adelaide Crescent
    BN3 2JE Hove
    East Sussex
    British75329780001
    ESSACK, Ismail
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Segretario
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    180702250001
    THICKBROOM, Mark Gordon
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Segretario
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    150676770001
    WALKER, Edward Ian Charles
    Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    1
    Hampshire
    England
    Segretario
    Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    1
    Hampshire
    England
    208796400001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BOWDEN ROOKE, Stuart Lee
    14 Mansell Close
    NN12 7AY Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    14 Mansell Close
    NN12 7AY Towcester
    Northamptonshire
    British142390750001
    CHAPMAN, Stuart Malcolm
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    14
    United Kingdom
    Amministratore
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish98452660001
    CLARK, David William
    Gilbury Farm
    Gilbury Lane
    SO45 1AG Exbury
    Hampshire
    Amministratore
    Gilbury Farm
    Gilbury Lane
    SO45 1AG Exbury
    Hampshire
    EnglandBritish91168600003
    EAGLE, Anthony Joseph
    6 Adelaide Crescent
    BN3 2JE Hove
    East Sussex
    Amministratore
    6 Adelaide Crescent
    BN3 2JE Hove
    East Sussex
    United KingdomBritish75329780001
    ESSACK, Ismail
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    EnglandBritish67640350001
    KEANE, Adrian Spencer
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    Amministratore
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    United KingdomBritish62552110002
    MACKIE, Graham Robert
    4 The Paddocks
    MK43 8LT Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    4 The Paddocks
    MK43 8LT Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish123305710001
    MEECHAN, Richard John
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    EnglandBritish167193130001
    READ, Jonathan Hugh Tobias
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    United KingdomBritish154632910001
    SADIQ, Hassan Saadi
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Silverstone
    Technology Park Silverstone
    NN12 8GX Circuit Silverstone
    Clark House
    Northamptonshire
    United KingdomBritish118639040001
    SALMON, Steven Kenneth
    Valley Farm
    Hanbury Road
    B60 4HJ Hanbury
    Worcestershire
    Amministratore
    Valley Farm
    Hanbury Road
    B60 4HJ Hanbury
    Worcestershire
    EnglandBritish142390760001
    THICKBROOM, Mark
    Technology Park, Silverstone Circuit
    Silverstone
    NN12 8GX Towcester
    Clark House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Technology Park, Silverstone Circuit
    Silverstone
    NN12 8GX Towcester
    Clark House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish116064810002
    WILLIAMS, Mark Pritchard
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    England
    Amministratore
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Highfield Court
    England
    EnglandBritish198092340001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INGLEBY SUB LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Home Ground Barn
    Pury Hill Business Park
    NN12 7LS Towcester
    2nd Floor
    England
    04 giu 2016
    Home Ground Barn
    Pury Hill Business Park
    NN12 7LS Towcester
    2nd Floor
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05436711
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    INGLEBY SUB LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 giu 2015
    Consegnato il 23 giu 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 26 mar 2012
    Consegnato il 31 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dfj Esprit LLP as Security Trustee for Each Group Member
    Transazioni
    • 31 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 september 2005 and
    Creato il 10 lug 2010
    Consegnato il 21 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deposit deed
    Creato il 23 set 2005
    Consegnato il 30 set 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £85,187.50 and any interest thereon for the time being standing to the credit of the seperate designated interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Silverstone Estates Limited
    Transazioni
    • 30 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage of a life policy
    Creato il 19 set 2005
    Consegnato il 01 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All money including bonuses that have accrued or may become payable under the policy, the benefit of all options and rights given in connection with the policy and all rights and interests in the policy. The policy means the life assurance policy on the life of mr david clark dated 26TH january 2004 with the financial services limited policy number 010644900-2 in the sum of £500,000 for a period of 5 years.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 19 set 2005
    Consegnato il 01 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 19 set 2005
    Consegnato il 01 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Intellectual property rights charge
    Creato il 19 set 2005
    Consegnato il 01 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights in rights and patents know-how registered trade marks registered designs utility models applications for the rights to apply for any of the foregoing unregistered design rights unregistered trade marks the rights to prevent passing off for unfair competition and copyright database rights topography rights and any other rights. The goodwill relating to any of the intellectual property. Every item of physical material of any description in respect of which the intellectual property rights may subsist. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 31 ott 2002
    Consegnato il 05 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,675.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    A designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society.
    Persone aventi diritto
    • David George King and Carolyn Margaret King
    Transazioni
    • 05 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0