INGLEBY SUB LIMITED
Panoramica
| Nome della società | INGLEBY SUB LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04240184 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INGLEBY SUB LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova INGLEBY SUB LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Highfield Court Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INGLEBY SUB LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ROAD ANGEL GROUP LIMITED | 28 set 2006 | 28 set 2006 |
| BLACK SPOT INTERACTIVE LIMITED | 13 set 2001 | 13 set 2001 |
| EGGSHELL (467) LIMITED | 25 giu 2001 | 25 giu 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INGLEBY SUB LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per INGLEBY SUB LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Pritchard Williams come amministratore in data 28 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stefan Leon Borson come amministratore in data 07 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Edward Ian Charles Walker come segretario in data 07 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS England a Highfield Court Tollgate Chandler's Ford Eastleigh SO53 3TY in data 13 feb 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 giu 2017 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Ingleby (1653) Limited come persona con controllo significativo il 04 giu 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Clark House Silverstone Technology Park Silverstone Circuit Silverstone Northamptonshire NN12 8GX a 2nd Floor, Home Ground Barn Pury Hill Business Park Towcester NN12 7LS in data 09 gen 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 25 pagine | AA | ||||||||||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Edward Ian Charles Walker come segretario in data 31 mag 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di INGLEBY SUB LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORSON, Stefan Leon | Amministratore | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court England | England | British | 117811010002 | |||||
| EAGLE, Anthony Joseph | Segretario | 6 Adelaide Crescent BN3 2JE Hove East Sussex | British | 75329780001 | ||||||
| ESSACK, Ismail | Segretario | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | 180702250001 | |||||||
| THICKBROOM, Mark Gordon | Segretario | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | 150676770001 | |||||||
| WALKER, Edward Ian Charles | Segretario | Barnes Wallis Road PO15 5UA Fareham 1 Hampshire England | 208796400001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| BOWDEN ROOKE, Stuart Lee | Amministratore | 14 Mansell Close NN12 7AY Towcester Northamptonshire | British | 142390750001 | ||||||
| CHAPMAN, Stuart Malcolm | Amministratore | Buckingham Gate SW1E 6LB London 14 United Kingdom | United Kingdom | British | 98452660001 | |||||
| CLARK, David William | Amministratore | Gilbury Farm Gilbury Lane SO45 1AG Exbury Hampshire | England | British | 91168600003 | |||||
| EAGLE, Anthony Joseph | Amministratore | 6 Adelaide Crescent BN3 2JE Hove East Sussex | United Kingdom | British | 75329780001 | |||||
| ESSACK, Ismail | Amministratore | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | England | British | 67640350001 | |||||
| KEANE, Adrian Spencer | Amministratore | Dale Acre Barn Main Street DE74 2RH Lockington Derby | United Kingdom | British | 62552110002 | |||||
| MACKIE, Graham Robert | Amministratore | 4 The Paddocks MK43 8LT Bedford Bedfordshire | England | British | 123305710001 | |||||
| MEECHAN, Richard John | Amministratore | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | England | British | 167193130001 | |||||
| READ, Jonathan Hugh Tobias | Amministratore | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | United Kingdom | British | 154632910001 | |||||
| SADIQ, Hassan Saadi | Amministratore | Silverstone Technology Park Silverstone NN12 8GX Circuit Silverstone Clark House Northamptonshire | United Kingdom | British | 118639040001 | |||||
| SALMON, Steven Kenneth | Amministratore | Valley Farm Hanbury Road B60 4HJ Hanbury Worcestershire | England | British | 142390760001 | |||||
| THICKBROOM, Mark | Amministratore | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Clark House Northamptonshire England | United Kingdom | British | 116064810002 | |||||
| WILLIAMS, Mark Pritchard | Amministratore | Tollgate Chandler's Ford SO53 3TY Eastleigh Highfield Court England | England | British | 198092340001 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di INGLEBY SUB LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingleby (1653) Limited | 04 giu 2016 | Home Ground Barn Pury Hill Business Park NN12 7LS Towcester 2nd Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
INGLEBY SUB LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 23 giu 2015 Consegnato il 23 giu 2015 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 mar 2012 Consegnato il 31 mar 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 september 2005 and | Creato il 10 lug 2010 Consegnato il 21 lug 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit deed | Creato il 23 set 2005 Consegnato il 30 set 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £85,187.50 and any interest thereon for the time being standing to the credit of the seperate designated interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of a life policy | Creato il 19 set 2005 Consegnato il 01 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All money including bonuses that have accrued or may become payable under the policy, the benefit of all options and rights given in connection with the policy and all rights and interests in the policy. The policy means the life assurance policy on the life of mr david clark dated 26TH january 2004 with the financial services limited policy number 010644900-2 in the sum of £500,000 for a period of 5 years. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 set 2005 Consegnato il 01 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 19 set 2005 Consegnato il 01 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Intellectual property rights charge | Creato il 19 set 2005 Consegnato il 01 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All rights in rights and patents know-how registered trade marks registered designs utility models applications for the rights to apply for any of the foregoing unregistered design rights unregistered trade marks the rights to prevent passing off for unfair competition and copyright database rights topography rights and any other rights. The goodwill relating to any of the intellectual property. Every item of physical material of any description in respect of which the intellectual property rights may subsist. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 31 ott 2002 Consegnato il 05 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3,675.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari A designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0