RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED

RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRETAIL VALUE NOMINEES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04244806
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sixth Floor, 150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAJORDRINK LIMITED02 lug 200102 lug 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Paul James Clifford come amministratore in data 06 feb 2023

    2 pagineAP01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Alexander David Lawson Stokoe come amministratore in data 16 dic 2022

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    5 pagineAA

    Nomina di Alexander David Lawson Stokoe come amministratore in data 01 gen 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christian Judd come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ms Diane Duncan come amministratore in data 28 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jennifer Anne Lisbey come amministratore in data 28 feb 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Jennifer Anne Lisbey come amministratore in data 23 ago 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew James Torode come amministratore in data 23 ago 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Ross St. John Judd il 27 giu 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Christian Ross St. John Judd come amministratore in data 16 feb 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Leonard Grose come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del segretario cambiati per Hermes Secretariat Limited il 31 gen 2018

    1 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HERMES SECRETARIAT LIMITED
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Segretario
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione3717842
    93700910001
    CLIFFORD, Paul James
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishAssociate Director, Operations Private Markets305198430001
    DUNCAN, Diane
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    United KingdomBritishAccountant172521350001
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant155163600003
    GREEN, Michelle Simone
    Daleham Mews
    NW3 5DB London
    25a
    United Kingdom
    Segretario
    Daleham Mews
    NW3 5DB London
    25a
    United Kingdom
    British59740190001
    LE GRICE, Frederick William
    46 Victor Gardens
    Hawkwell
    SS5 4DS Hockley
    Essex
    Segretario
    46 Victor Gardens
    Hawkwell
    SS5 4DS Hockley
    Essex
    British8792920001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Elizabeth Ann
    10 Sunlight Square
    Bethnal Green
    E2 6LD London
    Amministratore
    10 Sunlight Square
    Bethnal Green
    E2 6LD London
    BritishChartered Accountant83483930001
    ALLEN, Stephen
    4 Mulberry Close
    Gidea Park
    RM2 6DX Romford
    Essex
    Amministratore
    4 Mulberry Close
    Gidea Park
    RM2 6DX Romford
    Essex
    United KingdomBritishChartered Accountant109415360001
    BLACK, Russell Norman
    Meadow Way
    Boxmoor
    HP3 0AT Hemel Hempstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Meadow Way
    Boxmoor
    HP3 0AT Hemel Hempstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Manager97983900003
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector Taxation100504300001
    CLARK, Christopher Dean
    3 Florin Court
    8 Dock Street
    E1 8JR London
    Amministratore
    3 Florin Court
    8 Dock Street
    E1 8JR London
    BritishPrivate Equity Fund Manager76781680002
    COUPE, Frederick David Richard
    147 Vaughan Road
    Harrow
    HA1 4EG London
    Amministratore
    147 Vaughan Road
    Harrow
    HA1 4EG London
    United KingdomBritishChartered Surveyor73478680004
    DEWHIRST, Andrew David
    59 Old Park View
    EN2 7EQ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    59 Old Park View
    EN2 7EQ Enfield
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Accountant29539910003
    FRANKLIN, Jennifer Ann
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Amministratore
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    EnglandBritishReal Estate Finance Manager154430800001
    GROSE, David Leonard
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    United KingdomBritishAccountant120479020004
    JUDD, Christian
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    EnglandIrishAccountant243637570002
    LISBEY, Jennifer Anne
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant259968930001
    MARTIN, Andrew John, Mr.
    Hazelryst Rystwood Road
    RH18 5LX Forest Row
    East Sussex
    Amministratore
    Hazelryst Rystwood Road
    RH18 5LX Forest Row
    East Sussex
    EnglandBritishChartered Surveyor3565840001
    MOUSLEY, Emily Ann
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Amministratore
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    EnglandBritishChartered Accountant155262770003
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Amministratore
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritishChartered Accountant155262770001
    PIERCE, Graham Charles
    66 Lausanne Road
    SE15 2JB London
    Amministratore
    66 Lausanne Road
    SE15 2JB London
    United KingdomUkAccountant123665160001
    STOKOE, Alexander David Lawson
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant278764560001
    TORODE, Matthew James
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    United KingdomBritishFinance Manager196412900002
    YIANNACOU, Helen
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Amministratore
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    United KingdomBritishFinance Manager136737020001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    06 apr 2016
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4171096
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RETAIL VALUE NOMINEES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 ott 2003
    Consegnato il 11 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the retail value limited partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    54 above bar, southampton. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 24 gen 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    489 aylestone road and land adjoining leicester, leicestershire t/n LT268257 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon. Any goodwill relating to the property or the business by way of assignment the rents profits income fees and other sums at any time payable by any lessees underlessees tenants or licensees to the property together with the beenfit of all rights and remedies, the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 2002
    Consegnato il 16 gen 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    21, 21A, 23 and 23A tavern street ipswich and land lying to the south of tower church yard ipswich suffolk t/nos: SK6441 and SK163688. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 2002
    Consegnato il 16 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the west side of portswood road southampton hampshire t/no: HP285503. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 2002
    Consegnato il 16 gen 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    86-96 london road north lowestoft suffolk t/no: SK184761. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 2002
    Consegnato il 16 gen 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    56 high street, 3/3A north street and 1 park street ashford kent t/nos: K79453 and K242417. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 2001
    Consegnato il 19 ott 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1,2,3,3A and 3B queens rd,17 market place and 18 market place,nuneaton,warwickshire; t/nos WK242423 and WK323922; 24-30 strait bargate,boston,lincolnshire; ll 88311; 14,15,16,17,18 and 18A oxford st,swansea; t/no wa 67606; see form 395 for details. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 2001
    Consegnato il 19 ott 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    14 cornhill,bury st edmunds,suffolk; 51 and 53 english st,carlisle,cumbria; t/no cu 128135; 19 eastgate st,gloucester,gloucestershire; gr 185869; 54/56 parade and 3/5 bedford st,leamington spa,warwickshire; wk 139392; various other properties listed; see form 395 for details. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0