TOTAL POLYFILM LIMITED

TOTAL POLYFILM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOTAL POLYFILM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04253528
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOTAL POLYFILM LIMITED?

    • fabbricazione di articoli di imballaggio in plastica (22220) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova TOTAL POLYFILM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Interpath Ltd 10th Floor
    One Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOTAL POLYFILM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TYCO PLASTICS LIMITED14 ago 200114 ago 2001
    CONTINENTAL SHELF 197 LIMITED17 lug 200117 lug 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOTAL POLYFILM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per TOTAL POLYFILM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    24 pagineLIQ14

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 st Peters Square Manchester M2 3AE a C/O Interpath Ltd 10th Floor One Marsden Street Manchester M2 1HW in data 15 mar 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 ott 2021

    31 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    30 pagine600

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    28 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    5 pagineAM07

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    113 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    38 pagineAM02

    Cessazione della carica di Alastair Lloyd Murdoch come amministratore in data 27 set 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 95 Seedlee Road Walton Summit Industrial Estate Preston Lancashire PR5 8AE a 1 st Peters Square Manchester M2 3AE in data 30 set 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    36 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    31 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    10 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di David Murray Dawson come amministratore in data 07 nov 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 042535280010 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 042535280011, creata il 14 lug 2017

    39 pagineMR01

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    32 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TOTAL POLYFILM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PILLING, Trevor
    22 Pendle Drive
    Whalley
    BB7 9JT Clitheroe
    Lancashire
    Segretario
    22 Pendle Drive
    Whalley
    BB7 9JT Clitheroe
    Lancashire
    British98260120002
    DEAN, Darren William, Mr
    10th Floor
    One Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    C/O Interpath Ltd
    Amministratore
    10th Floor
    One Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    C/O Interpath Ltd
    United KingdomBritishDirector192864810001
    PILLING, Trevor
    22 Pendle Drive
    Whalley
    BB7 9JT Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    22 Pendle Drive
    Whalley
    BB7 9JT Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritishFinancial Director98260120002
    SEDGLEY, Robert Alan
    97 Wentworth Road
    Golders Green
    NW11 0RH London
    Segretario
    97 Wentworth Road
    Golders Green
    NW11 0RH London
    BritishCompany Director68531240002
    WEBB, Paul Christopher
    The Pool House
    Cottage Lane Shottery
    CV37 9HH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Pool House
    Cottage Lane Shottery
    CV37 9HH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British50817250001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Segretario nominato
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BONE, Ian John Cameron
    3 Combe Royal Crescent
    Bathwick Hill
    BA2 6EZ Bath
    Amministratore
    3 Combe Royal Crescent
    Bathwick Hill
    BA2 6EZ Bath
    EnglandBritishManaging Director98025600001
    BONE, Ian John Cameron
    3 Combe Royal Crescent
    Bathwick Hill
    BA2 6EZ Bath
    Amministratore
    3 Combe Royal Crescent
    Bathwick Hill
    BA2 6EZ Bath
    EnglandBritishManaging Director98025600001
    DAWSON, David Murray
    3 Crosslanes Barns
    Cruise Hill Lane, Elcocks Brook
    B97 5TR Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    3 Crosslanes Barns
    Cruise Hill Lane, Elcocks Brook
    B97 5TR Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector117800860001
    JONES, Colin Stuart Goodman
    36 Whinchat Grove
    DY10 4TJ Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    36 Whinchat Grove
    DY10 4TJ Kidderminster
    Worcestershire
    BritishSurveyor13002560001
    LITWINOWICZ, Leszek Richard
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector70815770002
    MANSI, Delmo Rinaldo Vincenzo Primo
    136 Calabria Road
    N5 1HT London
    Amministratore
    136 Calabria Road
    N5 1HT London
    EnglandBritishCompany Director62766640001
    MURDOCH, Alastair Lloyd
    9 Gala Avenue
    Deanpark
    PA4 0UH Renfrew
    Renfrewshire
    Amministratore
    9 Gala Avenue
    Deanpark
    PA4 0UH Renfrew
    Renfrewshire
    ScotlandBritishAccountant98780900001
    PILLING, Trevor
    10 West Leigh Road
    BB1 8JR Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    10 West Leigh Road
    BB1 8JR Blackburn
    Lancashire
    BritishFinance Director98260120001
    SEDGLEY, Robert Alan
    97 Wentworth Road
    Golders Green
    NW11 0RH London
    Amministratore
    97 Wentworth Road
    Golders Green
    NW11 0RH London
    BritishCompany Director68531240002
    STEFANI, Micelangelo Federico
    Chateau D Assenois
    Route De La Gaume 13
    Assenois
    6860
    Belgium
    Amministratore
    Chateau D Assenois
    Route De La Gaume 13
    Assenois
    6860
    Belgium
    ItalianLawyer77781050001
    SUTTER, Terry
    197 Pottersville Road
    FOREIGN Chester
    New Jersey
    Usa
    Amministratore
    197 Pottersville Road
    FOREIGN Chester
    New Jersey
    Usa
    AmericanManaging Director91025940001
    WEBB, Paul Christopher
    The Pool House
    Cottage Lane Shottery
    CV37 9HH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    The Pool House
    Cottage Lane Shottery
    CV37 9HH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishConsultant50817250001
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Amministratore delegato nominato
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TOTAL POLYFILM LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Total Polyfilm (Holdings) Limited
    Seedlee Road, Walton Summit Centre
    Bamber Bridge
    PR5 8AE Preston
    95
    England
    17 lug 2016
    Seedlee Road, Walton Summit Centre
    Bamber Bridge
    PR5 8AE Preston
    95
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione05202458
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    TOTAL POLYFILM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 lug 2017
    Consegnato il 24 lug 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 24 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 gen 2017
    Consegnato il 11 gen 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 dic 2015
    Consegnato il 29 dic 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 29 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Chattel mortgage
    Creato il 20 dic 2011
    Consegnato il 23 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its plant and machinery listed in schedule 1 of the mortgage, all benefits arising under the policies, any contracts relating to the plant and machinery and by way of floating charge all the undertaking, property, rights and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 08 nov 2007
    Consegnato il 10 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 10 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 mag 2005
    Consegnato il 09 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as tyco plastics limited) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tyco Holdings (UK) Limited
    Transazioni
    • 09 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 27 mag 2005
    Consegnato il 09 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as tyco plastics limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tyco Group Sarl
    Transazioni
    • 09 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mag 2005
    Consegnato il 02 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as tyco plastics limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 27 mag 2005
    Consegnato il 02 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as tyco plastics limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 95 seedlee road walton summit centre bamber bridge preston lancashire t/n la 655886.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 mag 2005
    Consegnato il 02 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as tyco plastics limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a cranbourne road industrial estate potters bar hertfordshire t/n hd 244930.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 mag 2005
    Consegnato il 02 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as tyco plastics limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 3 armytage road brighouse west yorkshire t/n wyk 139811.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TOTAL POLYFILM LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 set 2019Inizio dell'amministrazione
    22 ott 2020Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David James Costley-Wood
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praticante
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Richard John Harrison
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    2
    DataTipo
    22 ott 2020Inizio della liquidazione
    10 apr 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David James Costley-Wood
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praticante
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Richard John Harrison
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praticante
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Howard Smith
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0