BRENNTAG UK GROUP LIMITED

BRENNTAG UK GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRENNTAG UK GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04253894
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRENNTAG UK GROUP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BRENNTAG UK GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Alpha House
    Lawnswood Business Park, Redvers Close
    LS16 6QY Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRENNTAG UK GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALBION GROUP LIMITED23 lug 200123 lug 2001
    WOODLAND 1 LIMITED17 lug 200117 lug 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRENNTAG UK GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per BRENNTAG UK GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Albion House Rawdon Park Green Lane Yeadon Leeds West Yorkshire LS19 7XX a Alpha House Lawnswood Business Park, Redvers Close Leeds LS16 6QY in data 26 ott 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 apr 2016

    Stato del capitale al 14 apr 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 apr 2015

    Stato del capitale al 16 apr 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Clare Marie Waters come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Russel Argo come amministratore in data 31 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Clare Marie Waters come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    41 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 apr 2014

    Stato del capitale al 10 apr 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Stato del capitale al 09 ott 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di David O'connell come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BRENNTAG UK GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRATTON, Martin
    Lawnswood Business Park, Redvers Close
    LS16 6QY Leeds
    Alpha House
    England
    Segretario
    Lawnswood Business Park, Redvers Close
    LS16 6QY Leeds
    Alpha House
    England
    British90371670001
    ARGO, Russel Ian
    Lawnswood Business Park, Redvers Close
    LS16 6QY Leeds
    Alpha House
    England
    Amministratore
    Lawnswood Business Park, Redvers Close
    LS16 6QY Leeds
    Alpha House
    England
    EnglandBritish196827670001
    GRATTON, Martin
    Lawnswood Business Park, Redvers Close
    LS16 6QY Leeds
    Alpha House
    England
    Amministratore
    Lawnswood Business Park, Redvers Close
    LS16 6QY Leeds
    Alpha House
    England
    EnglandBritish90371670002
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Segretario
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    British124446000001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Segretario
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    39754020001
    BATCHELOR, Nigel Maurice
    3 The Green
    Wimbledon
    SW19 5AZ London
    Amministratore
    3 The Green
    Wimbledon
    SW19 5AZ London
    EnglandBritish62010280003
    BLOMME, Carl Marcel
    Aardbezienstraat 2
    Heule
    8501
    Belguim
    Amministratore
    Aardbezienstraat 2
    Heule
    8501
    Belguim
    Belgian113214990001
    BUCHSTEINER, Jurgen
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    GermanyGermany114612200001
    CORTAZZI, William Julian
    38 Gloucester Square
    W2 2TD London
    Amministratore
    38 Gloucester Square
    W2 2TD London
    United KingdomBritish46234910004
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Amministratore
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritish124446000001
    HOLLAND, Steven Edward
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish62261990002
    LOCKWOOD, Ian
    10 Wondesford Dale
    RG42 5TG Binfield
    Berkshire
    Amministratore
    10 Wondesford Dale
    RG42 5TG Binfield
    Berkshire
    EnglandBritish117640860001
    MCLACHLAN, Neil Andrew
    Deise
    Langhurstwood Road
    RH12 4QD Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Deise
    Langhurstwood Road
    RH12 4QD Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish78366690001
    O'CONNELL, David Michael
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish124960420001
    PATTYN, Marc Achiel Valeer
    Driepikkelstraaty 12
    Ledegem
    8880
    Belgium
    Amministratore
    Driepikkelstraaty 12
    Ledegem
    8880
    Belgium
    Belgian113475580001
    PITHOIS, Daniel Yves Andre
    4 Allee De La Pommeraie,
    91570
    Bievres
    France
    Amministratore
    4 Allee De La Pommeraie,
    91570
    Bievres
    France
    French114663980001
    SAVAGE, Peter James
    Woodlands Hurdle Way
    Compton Down
    SO21 2AN Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Woodlands Hurdle Way
    Compton Down
    SO21 2AN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish46555490001
    VAN BAARLEN, Arie Harry
    Wilhelminahoeve 16
    Krimpen Aan Den Ussel
    2924 Be
    Netherlands
    Amministratore
    Wilhelminahoeve 16
    Krimpen Aan Den Ussel
    2924 Be
    Netherlands
    NetherlandsDutch114573830001
    WATERS, Clare Marie
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Albion House Rawdon Park
    Green Lane Yeadon
    LS19 7XX Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish124960910001
    WILLIAMS, Graham John
    Merstham Lodge
    Harps Oak Lane
    RH1 3AN Merstham
    Surrey
    Amministratore
    Merstham Lodge
    Harps Oak Lane
    RH1 3AN Merstham
    Surrey
    EnglandBritish5458110001
    MH DIRECTORS LIMITED
    12 Great James Street
    WC1N 3DR London
    Amministratore
    12 Great James Street
    WC1N 3DR London
    40574860001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BRENNTAG UK GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lawnswood Business Park, Redvers Close
    LS16 6QY Leeds
    Alpha House
    England
    06 apr 2016
    Lawnswood Business Park, Redvers Close
    LS16 6QY Leeds
    Alpha House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05777067
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    BRENNTAG UK GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 set 2006
    Consegnato il 02 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transazioni
    • 02 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over deposit
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 06 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge its entire right title and interest in and to the deposit and all rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 29 gen 2003
    Consegnato il 01 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a land off leagrave road luton in the county of bedford having an area of 11,200 square metres or thereabouts.
    Persone aventi diritto
    • Hays Holdings Limited
    Transazioni
    • 01 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture to a composite guarantee and debenture dated 28 july 2001
    Creato il 23 gen 2003
    Consegnato il 06 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Securitybeneficiaries) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 23 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a land and buildings comprising part of the old brick and tile works portishead bristol and all that piece of land formerly part of the dellacassa site adjoining the land. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hays Holdings Limited
    Transazioni
    • 23 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture to a composite guarantee and debenture dated 28 july 2001
    Creato il 19 dic 2002
    Consegnato il 07 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness,liabilities and obligations due or to become due in any manner whatsoever by any group company to the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,London as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transazioni
    • 07 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 28 lug 2001
    Consegnato il 13 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Akk monies due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee under the subordinated security documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hays Holdings Limited
    Transazioni
    • 13 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 28 lug 2001
    Consegnato il 09 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise, on any account whatsoever (all terms as defined)
    Brevi particolari
    F/H property k/a station road attleborough t/n NK130601, unit 3 nechells business centre dollman street birmingham WM538203 (for furthur property details please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Security Beneficiaries) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0