THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED

THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04258762
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    • (6523) /

    Dove si trova THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THINC DESTINI TRAIL COLLECTIONS LIMITED18 lug 200618 lug 2006
    DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED29 apr 200529 apr 2005
    DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP PLC27 giu 200227 giu 2002
    GREENOAK MARKETING GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY30 ago 200130 ago 2001
    INDIGOHONEY PUBLIC LIMITED COMPANY25 lug 200125 lug 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 29 dic 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account and other reserve be reduced to zero 22/12/2011
    RES13

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    21 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Cessazione della carica di Alasdair Mackay come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Jeremy Peter Small il 23 apr 2010

    1 pagineCH03

    Nomina di Alasdair Mackay come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    16 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    BritishCompany Director67168210001
    ANDERSON, Philip John
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    UkBritishFinancial Director79136250001
    COLLETT, David
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    Segretario
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    BritishDirector101014620001
    O'CONOR, Patrick Francis
    51 Downs Park West
    BS6 7QL Bristol
    Somerset
    Segretario
    51 Downs Park West
    BS6 7QL Bristol
    Somerset
    British50372870001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Segretario
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    BritishDirector130449650001
    SMITH, Nicholas
    Corner Cottage
    Crab Mill Lane, Lea
    SN16 9PF Malmesbury
    Wiltshire
    Segretario
    Corner Cottage
    Crab Mill Lane, Lea
    SN16 9PF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishSolicitor83415330001
    CHANCERY NOMINEE SERVICES LIMITED
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    98153140001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRISTOL, Teresa Louise
    35 Sherbourne Street
    St George
    BS5 8EQ Bristol
    Amministratore
    35 Sherbourne Street
    St George
    BS5 8EQ Bristol
    BritishManager83991510001
    COLLETT, David
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    BritishDirector101014620001
    EVERILL, Jonathan Robert Edwin
    9 Brambles Close
    Ash
    GU12 6NY Aldershot
    Hampshire
    Amministratore
    9 Brambles Close
    Ash
    GU12 6NY Aldershot
    Hampshire
    BritishIfa34156430003
    EVERILL, Jonathon Robert Edwin
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    Amministratore
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    BritishFinancial Adviser105488120003
    GALVIN WRIGHT, Jonathon William
    9 Saint Helena Road
    BS6 7NR Bristol
    Amministratore
    9 Saint Helena Road
    BS6 7NR Bristol
    BritishMarketing Director79499790001
    GRIFFITHS, Mark Roderick Winton
    18 Portland Square
    BS2 8SJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    18 Portland Square
    BS2 8SJ Bristol
    Avon
    BritishSolicitor61034080001
    LINDLEY, Richard Malcolm
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    UkBritishCompany Director98560430001
    LUMSDEN COOK, Anthony James
    Warren House
    Blockley
    GL56 9HL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Amministratore
    Warren House
    Blockley
    GL56 9HL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    BritishLloyds Underwriter78707170001
    MACKAY, Alasdair Iain
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritishNone146368090001
    PARSONS, Barry Gilbert
    Falcon Lodge
    New Road Greens Norton
    NN12 8BW Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    Falcon Lodge
    New Road Greens Norton
    NN12 8BW Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector91796850001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Amministratore
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Operating Officer130449650001
    SCOTT, Graham Leslie
    Millfield House
    Church Road
    SY3 9HQ Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Millfield House
    Church Road
    SY3 9HQ Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishIndependent Financial Adviser78187980001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Amministratore delegato nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 25 nov 2005
    Consegnato il 10 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 nov 2005
    Consegnato il 08 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential UK Services Limited
    Transazioni
    • 08 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 04 giu 2003
    Consegnato il 21 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Scottish equitable policy no: L0194075832 dl (barry gilbert parsons). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 04 giu 2003
    Consegnato il 21 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Scottish equitable policy no: L0192175832 dt (david john collett). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 apr 2003
    Consegnato il 09 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0