THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04258762 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?
- (6523) /
Dove si trova THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 5 Old Broad Street EC2N 1AD London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
THINC DESTINI TRAIL COLLECTIONS LIMITED | 18 lug 2006 | 18 lug 2006 |
DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED | 29 apr 2005 | 29 apr 2005 |
DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP PLC | 27 giu 2002 | 27 giu 2002 |
GREENOAK MARKETING GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | 30 ago 2001 | 30 ago 2001 |
INDIGOHONEY PUBLIC LIMITED COMPANY | 25 lug 2001 | 25 lug 2001 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Stato del capitale al 29 dic 2011
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 21 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Alasdair Mackay come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 apr 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jeremy Peter Small il 23 apr 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Nomina di Alasdair Mackay come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di un amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMALL, Jeremy Peter | Segretario | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | British | Company Director | 67168210001 | |||||
ANDERSON, Philip John | Amministratore | 1 Warmans Close Bawburgh NR9 3JB Norwich Norfolk | Uk | British | Financial Director | 79136250001 | ||||
COLLETT, David | Segretario | 4 Silver Street GL8 8DH Tetbury Gloucestershire | British | Director | 101014620001 | |||||
O'CONOR, Patrick Francis | Segretario | 51 Downs Park West BS6 7QL Bristol Somerset | British | 50372870001 | ||||||
RENNISON, Roderic Henry Patrick | Segretario | Westmill Lane Ickleford SG5 3RP Hitchin Old Westmill Farmhouse Hertfordshire | British | Director | 130449650001 | |||||
SMITH, Nicholas | Segretario | Corner Cottage Crab Mill Lane, Lea SN16 9PF Malmesbury Wiltshire | British | Solicitor | 83415330001 | |||||
CHANCERY NOMINEE SERVICES LIMITED | Segretario | Chancery Pavilion Boycott Avenue Oldbrook MK6 2TA Milton Keynes Buckinghamshire | 98153140001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BRISTOL, Teresa Louise | Amministratore | 35 Sherbourne Street St George BS5 8EQ Bristol | British | Manager | 83991510001 | |||||
COLLETT, David | Amministratore | 4 Silver Street GL8 8DH Tetbury Gloucestershire | British | Director | 101014620001 | |||||
EVERILL, Jonathan Robert Edwin | Amministratore | 9 Brambles Close Ash GU12 6NY Aldershot Hampshire | British | Ifa | 34156430003 | |||||
EVERILL, Jonathon Robert Edwin | Amministratore | Sandbanks Road BH14 8EY Poole 277 Dorset | British | Financial Adviser | 105488120003 | |||||
GALVIN WRIGHT, Jonathon William | Amministratore | 9 Saint Helena Road BS6 7NR Bristol | British | Marketing Director | 79499790001 | |||||
GRIFFITHS, Mark Roderick Winton | Amministratore | 18 Portland Square BS2 8SJ Bristol Avon | British | Solicitor | 61034080001 | |||||
LINDLEY, Richard Malcolm | Amministratore | 2 Kensington Place Wellingborough Road MK46 4BG Olney Buckinghamshire | Uk | British | Company Director | 98560430001 | ||||
LUMSDEN COOK, Anthony James | Amministratore | Warren House Blockley GL56 9HL Moreton In Marsh Gloucestershire | British | Lloyds Underwriter | 78707170001 | |||||
MACKAY, Alasdair Iain | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1AD London 5 | United Kingdom | British | None | 146368090001 | ||||
PARSONS, Barry Gilbert | Amministratore | Falcon Lodge New Road Greens Norton NN12 8BW Towcester Northamptonshire | British | Director | 91796850001 | |||||
RENNISON, Roderic Henry Patrick | Amministratore | Westmill Lane Ickleford SG5 3RP Hitchin Old Westmill Farmhouse Hertfordshire | England | British | Chief Operating Officer | 130449650001 | ||||
SCOTT, Graham Leslie | Amministratore | Millfield House Church Road SY3 9HQ Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Independent Financial Adviser | 78187980001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 25 nov 2005 Consegnato il 10 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 25 nov 2005 Consegnato il 08 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of life policy | Creato il 04 giu 2003 Consegnato il 21 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Scottish equitable policy no: L0194075832 dl (barry gilbert parsons). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of life policy | Creato il 04 giu 2003 Consegnato il 21 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Scottish equitable policy no: L0192175832 dt (david john collett). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 25 apr 2003 Consegnato il 09 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0