OPAL (YORKSHIRE) LTD

OPAL (YORKSHIRE) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOPAL (YORKSHIRE) LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04263388
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OPAL (YORKSHIRE) LTD?

    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova OPAL (YORKSHIRE) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OPAL (YORKSHIRE) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STYWAY PROPERTIES LIMITED02 ago 200102 ago 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di OPAL (YORKSHIRE) LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per OPAL (YORKSHIRE) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2018

    6 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2017

    7 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da The Place Ducie Street Manchester M1 2TP a 15 Canada Square London E14 5GL in data 20 ott 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2016

    LRESSP

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    47 pagine1.4

    Cessazione della carica di Brett Alan Lashley come amministratore in data 04 giu 2015

    2 pagineTM01

    Nomina di Richard Spencer come amministratore in data 04 giu 2015

    3 pagineAP01

    Nomina di Brett Alan Lashley come amministratore in data 25 feb 2015

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Craig Allan Mellor come segretario in data 25 feb 2015

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Stuart Barrie Wall come amministratore in data 25 feb 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Craig Allan Mellor come amministratore in data 25 feb 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gavin Robert Duncan come amministratore in data 25 feb 2015

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a The Place Ducie Street Manchester M1 2TP in data 06 mar 2015

    2 pagineAD01

    Avviso di termine dell'amministrazione

    72 pagine2.32B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 gen 2015

    67 pagine2.24B

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 dic 2014

    2 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    9 pagine1.1

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 lug 2014

    90 pagine2.24B

    Chi sono gli amministratori di OPAL (YORKSHIRE) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPENCER, Richard James
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    Amministratore
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish190526870001
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Segretario
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    DUNCAN, Gavin Robert
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Amministratore
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish151512820001
    LASHLEY, Brett Alan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Amministratore
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandUnited States Of America196201790001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    MELLOR, Craig Allan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Amministratore
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish60906780002
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    Amministratore
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    OPAL (YORKSHIRE) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Group debenture
    Creato il 04 apr 2012
    Consegnato il 19 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 218 nov 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 219 dic 2014Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 2
    Assignment by way of security
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 05 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the agreements and all rights contained therein and all monies and/or benefits from time to time accruing thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 09 ago 2006
    Consegnato il 22 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 22 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 ago 2006
    Consegnato il 22 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or its associated companies on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at pitfield street youth centre pifield street hackney t/no EGL438260 the rental income the benefit of all guarantees the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 22 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 20 giu 2003
    Consegnato il 01 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate at the junction of thornton road and tumbling hill street bradford west yorks t/no WYK559561. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 15 gen 2002
    Consegnato il 25 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south side of tumbling hill street bradford t/n WYK681581. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2002
    Consegnato il 25 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    OPAL (YORKSHIRE) LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 mar 2013Inizio dell'amministrazione
    20 feb 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Ricevitore/gestore
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Ricevitore/gestore
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    3
    DataTipo
    12 dic 2014Data della riunione per approvare il CVA
    22 ott 2015Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    4
    DataTipo
    30 set 2016Inizio della liquidazione
    02 ago 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0