BROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED

BROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04264988
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova BROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingddon
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOKE OFFICE PARK (2001) LIMITED21 set 200121 set 2001
    LEADSHINE LIMITED06 ago 200106 ago 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di BROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 ago 2012

    Stato del capitale al 24 ago 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di David Logue come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Anthony Donnelly come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per David Iain Logue il 03 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    11 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di BROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    DONNELLY, Anthony
    Old Kirk Road
    EH12 6JY Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Kirk Road
    EH12 6JY Edinburgh
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish109258700001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    LOGUE, David Iain
    6 Colebrook Street
    Kelvinbridge
    G12 8HD Glasgow
    2/1
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Colebrook Street
    Kelvinbridge
    G12 8HD Glasgow
    2/1
    United Kingdom
    United KingdomBritish91223970002
    MCARDLE, Ian
    Grayway Close
    Highfield Caldecote
    CB23 7UZ Cambridge
    3
    Amministratore
    Grayway Close
    Highfield Caldecote
    CB23 7UZ Cambridge
    3
    United KingdomBritish135426570001
    MEIKLE, Alan Malcolm
    3 Glebe Terrace
    EH12 7SQ Edinburgh
    Amministratore
    3 Glebe Terrace
    EH12 7SQ Edinburgh
    ScotlandBritish117570760001
    ROBERTS, David Anthony
    74 The Crescent
    Henleaze
    BS9 4RR Bristol
    S Glos
    Amministratore
    74 The Crescent
    Henleaze
    BS9 4RR Bristol
    S Glos
    United KingdomBritish98952830001
    RUDRUM, John Clifford
    St Arilds Farm
    Kington Lane Kington Thornbury
    BS35 1NQ Bristol
    Amministratore
    St Arilds Farm
    Kington Lane Kington Thornbury
    BS35 1NQ Bristol
    EnglandBritish18989400003
    RUDRUM, Trevor John
    Oldbury Naite
    BS35 1RU Oldbury On Severn
    Meads View
    Bristol
    Amministratore
    Oldbury Naite
    BS35 1RU Oldbury On Severn
    Meads View
    Bristol
    EnglandBritish61084430011
    RUSSELL, Peter
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    Amministratore
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    EnglandBritish10920180001
    WALLACE, Lesley Ann
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    British64383520003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    BROOK OFFICE PARK (2001) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of floating charge
    Creato il 17 dic 2001
    Consegnato il 21 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or morrison group limited and/or morrison developments limited and/or awg PLC and/or such financial institution under or pursuant to the agreements and the morrison security and the security documentation
    Brevi particolari
    The undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future (which secures present and future advances).
    Persone aventi diritto
    • Morrison Developments Property Finance Limited
    Transazioni
    • 21 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creato il 17 dic 2001
    Consegnato il 21 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or awg PLC and/or morrison group limited and/or awg developments limited and/or morrison PLC and/or such financial institution pursuant to the terms of the agreements and the morrison security and the security documentation.
    Brevi particolari
    All that f/h land at area b emersons green kendalshire farm winterbourne bristol t/n GR224204 together with all rights and interests in the same and all buildings structures fixtures and fittings (including trade fixtures) and all fixed plant and equipment of the time being thereon.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morrison Developments Property Finance Limited
    Transazioni
    • 21 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 dic 2001
    Consegnato il 18 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0