WWM PROPERTIES LIMITED

WWM PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWWM PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04269069
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WWM PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova WWM PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St. Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WWM PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per WWM PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    6 pagineMR04

    Bilancio di micro-entità redatto al 05 giu 2017

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 21 Shenley Hill Radlett Hertfordshire WD7 7AT a The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill Wheathampstead St. Albans Hertfordshire AL4 8AN in data 16 ago 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 01 ago 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 05 apr 2017 al 05 giu 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 05 apr 2016

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 lug 2015

    Stato del capitale al 27 lug 2015

    • Capitale: GBP 75
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 05 apr 2015

    3 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 042690690011, creata il 16 mar 2015

    6 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 lug 2014

    Stato del capitale al 29 lug 2014

    • Capitale: GBP 75
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 05 apr 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 26 lug 2013

    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 05 apr 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 05 apr 2012

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di WWM PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONE, Richard John
    21 Shenley Hill
    WD7 7AT Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    21 Shenley Hill
    WD7 7AT Radlett
    Hertfordshire
    BritishAccountant77137520002
    MALONE, Richard John
    21 Shenley Hill
    WD7 7AT Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    21 Shenley Hill
    WD7 7AT Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant77137520002
    WHITEMAN, John
    6 Grange Road
    Bushey
    WD23 2LE Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Grange Road
    Bushey
    WD23 2LE Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSurveyor77717910001
    WOODHEAD, Geoffrey John
    Little Meadows Gills Hollow
    WD7 8JJ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Little Meadows Gills Hollow
    WD7 8JJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSolicitor46515710001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WWM PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Richard John Malone
    Shenley Hill
    WD7 7AT Radlett
    21
    Hertfordshire
    England
    06 apr 2016
    Shenley Hill
    WD7 7AT Radlett
    21
    Hertfordshire
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WWM PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 mar 2015
    Consegnato il 19 mar 2015
    In corso
    Breve descrizione
    77 ethel street and 28 st edmunds road northampton.
    Persone aventi diritto
    • John Whiteman
    Transazioni
    • 19 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal mortgage
    Creato il 13 lug 2007
    Consegnato il 17 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the chambers 28 st edmunds road northampton. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 12 lug 2007
    Consegnato il 17 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a flat 4 the chambers 28 st edmunds road northampton t/no NN227866. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 11 lug 2007
    Consegnato il 17 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a flat 1 the chambers 28 st edmunds road northampton. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 04 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 37 pinner road oxhey watford t/n HD58409. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 04 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 08 ago 2005
    Consegnato il 13 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 29 high street sandy beds t/n BD244037. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 25 lug 2003
    Consegnato il 31 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 101A midland road bedford MK40 1BZ title number BD127622. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 31 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 02 ott 2002
    Consegnato il 09 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a flat 49 de parys avenue bedford BD128953. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 gen 2002
    Consegnato il 06 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including 14 cromwell court farrer st.kempston bedford; t/no bd 132642. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 06 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 2002
    Consegnato il 06 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 14 cromwell court farrer st kempton bedford t/n BD132642. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 06 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 26 ott 2001
    Consegnato il 30 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as flat 1,54A high st,kempston bedford MK42 7AL. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 30 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    WWM PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ago 2017Inizio della liquidazione
    22 giu 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Hayley Maddison
    The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    Hertfordshire
    Praticante
    The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    Hertfordshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0