TRINITY ONE LIMITED

TRINITY ONE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRINITY ONE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04269286
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRINITY ONE LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova TRINITY ONE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    52 Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRINITY ONE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TRINITY ONE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Mark Richard Bourgeois come amministratore in data 22 dic 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2015

    Stato del capitale al 20 ago 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Charles Appleyard come amministratore in data 03 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Bryan Womack come amministratore in data 15 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ago 2014

    Stato del capitale al 19 ago 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Mark Richard Bourgeois come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Xavier Pullen come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2013

    Stato del capitale al 20 ago 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Stuart Andrew Wetherly come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Falguni Desai come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Christopher Laxton come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Karen Fox come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    11 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TRINITY ONE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WETHERLY, Stuart Andrew
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    Segretario
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    177525940001
    FORD, Kenneth Charles
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Amministratore
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    EnglandBritishChartered Surveyor52710005
    STAVELEY, Charles Andrew Rover
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant133771640001
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Segretario
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    British77755390004
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Segretario
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    APPLEYARD, Andrew Charles
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Amministratore
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    United KingdomBritishFund Manager131498200001
    BARBER, Martin
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    Amministratore
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    BritishCompany Director35534320006
    BOURGEOIS, Mark Richard
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    Amministratore
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    EnglandBritishChartered Surveyor60776880004
    BOYLAND, Roger Michael
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    Amministratore
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    BritishChartered Accountant33984480006
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Amministratore
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritishCompany Director101932350001
    COPELAND, Anne Marie
    3 The Manor House
    Roxwell Road
    CM1 3RY Writtle
    Essex
    Amministratore
    3 The Manor House
    Roxwell Road
    CM1 3RY Writtle
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor87679960001
    CORAL, Lynda Sharon
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    Amministratore
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    BritishDirector Chartered Accountant34029880004
    FOX, Karen Julia
    The Roost
    Chinnor Road
    OX9 3QY Towersey
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Roost
    Chinnor Road
    OX9 3QY Towersey
    Oxfordshire
    BritishFund Manager116116000001
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Amministratore
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritishChartered Surveyor76584200002
    LAXTON, Chris James Wentworth
    The Green
    Saxlingham
    NR15 1TH Nethergate
    Grove Farm House
    Norfolk
    Amministratore
    The Green
    Saxlingham
    NR15 1TH Nethergate
    Grove Farm House
    Norfolk
    United KingdomBritishInsurance Company Official198871760001
    LEWIS PRATT, Andrew
    34 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    Amministratore
    34 Hillersdon Avenue
    Barnes
    SW13 0EF London
    BritishChartered Surveyor & Director60050050002
    NELL, Philip John Payton
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishFund Manager105566370001
    PATTERSON, Christopher Lindsay
    17 Chatsworth Avenue
    SW20 8JZ London
    Amministratore
    17 Chatsworth Avenue
    SW20 8JZ London
    BritishFund Manager86029780001
    PULLEN, Xavier
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    Amministratore
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    EnglandBritishCompany Director78912170008
    SUNNUCKS, William D'Urban
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    Amministratore
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    EnglandBritishChart Accountant32866350001
    WOMACK, Ian Bryan
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    Amministratore
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    EnglandBritishChartered Surveyor33902000006
    OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED
    Third Floor 90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    Amministratore
    Third Floor 90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    72502190001
    OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED
    90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    Amministratore
    90 Long Acre
    Covent Garden
    WC2E 9TT London
    72502080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TRINITY ONE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Trinity Aberdeen Limited
    The Esplanade
    St. Helier
    JE2 3QA Jersey
    One
    Channel Islands
    06 apr 2016
    The Esplanade
    St. Helier
    JE2 3QA Jersey
    One
    Channel Islands
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneJersey
    Autorità legaleJersey Law
    Luogo di registrazioneJfsc
    Numero di registrazione80724
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    TRINITY ONE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge (security and intercreditor deed)
    Creato il 05 mag 2005
    Consegnato il 23 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company the borrower or any other obligor or any limited obligor to the obligor security trustee or any of the other obligor secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H and l/h property, specified assets, book debts, obligor security group shares, intellectual property, insurances, obligor transaction documents, net rental income, agreements floating charge all undertaking property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited (For Itself and as Trustee for the Obligorsecured Creditors)
    Transazioni
    • 23 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Obligor/issuer floating charge agreement
    Creato il 05 mag 2005
    Consegnato il 18 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, the borrower or (in the case of the obligors only)any other obligor or any limited obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge, the whole of its undertaking and all property assets and rights present and future (including all stock in trade f/h and l/h property and balance standing to the credit of any client accounts),. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Mall Funding PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 9 may 2005 and
    Creato il 29 apr 2005
    Consegnato il 12 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any and all of the obligors to each of or all of the obligor secured creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the trinity centre union street in the city and county of aberdeen, all and whole those parts of the ground floor first basement level second basement level and third basement level of the building known as 157 to 165 union street and number 9 bridge street aberdeen t/n ABN28158, for details of further properties charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited (Obligor Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19 april 2004 and
    Creato il 06 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of the obligor to the security trustee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming all and whole the trinity centre, union street in the city and county of aberdeen, t/n ABN28158;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 apr 2004
    Consegnato il 16 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings to the south of main road romford (now k/a the dolphin centre) havering t/n EGL416981. L/h land and buildings lying to the north of western road romford (now k/a liberty ii shopping centre) havering t/n EGL347983. L/h land the upper deck car park mercury gardens romford t/n EGL435359 for details of further property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee and Agentfor the Finance Parties
    Transazioni
    • 16 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 20 ott 2003
    Consegnato il 07 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All assets rights and property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Itselfand as Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 07 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 21ST march 2002
    Creato il 28 feb 2002
    Consegnato il 06 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee as security trustee for the finance parties (all terms as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The trinity centre union street aberdeen t/no.ABN28158. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 2002
    Consegnato il 20 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that leasehold land being broadway shopping centre broadway bexleyheath in the london borough of bexley t/n SGL553179, all that freehold land being land and buildings to the south of main road romford (now known as the dolphin centre) havering t/n EGL416981 and all that leasehold land being land and buildings lying to the north of western road romford (known as liberty ii shopping centre) havering EGL347983 (for further details of property charged see schedule 3 of form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties (The Security Trustee) and (Theagent)
    Transazioni
    • 20 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security by capital and regional retail (northern) limited,registered in the land register of scotland on 30 december 1998
    Creato il 21 dic 1998
    Acquisito il 07 nov 2001
    Consegnato il 23 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The whole structure on south side of union bridge,aberdeen. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (Formerly Midland Bank PLC)
    Transazioni
    • 23 nov 2001Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 14 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security by capital and regional (northern) limited,recxorded in the general register of sasines (aberdeen) on 1 september 1998
    Creato il 25 ago 1998
    Acquisito il 07 nov 2001
    Consegnato il 23 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The subjects known as trinity centre,union st,city and county of aberdeen. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (Formerly Midland Bank PLC)
    Transazioni
    • 23 nov 2001Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 14 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0