LOGVALE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLOGVALE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04275100
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LOGVALE LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova LOGVALE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LOGVALE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per LOGVALE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2021

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2020

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2019

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Seymour Smit come segretario in data 31 lug 2020

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2018

    13 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2017

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2016

    6 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 30 City Road London EC1Y 2AB

    1 pagineAD04

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2015

    8 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    6 pagineMR04

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2015 al 30 nov 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ago 2015

    Stato del capitale al 27 ago 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Chi sono gli amministratori di LOGVALE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOKE, Paul Neville Rodney
    Stanny House Farm Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Stanny House Farm Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish6777340001
    KELLY, Crispin Noel
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    United Kingdom
    Amministratore
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    United Kingdom
    EnglandBritish2033150025
    COOKE, Katherine Louise Harriet
    Stanny House Farm
    Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    Segretario
    Stanny House Farm
    Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    British16243470001
    SMIT, Christopher Seymour
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    United Kingdom
    Segretario
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    United Kingdom
    British174356120002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    COOKE, Katherine Louise Harriet
    Stanny House Farm
    Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Stanny House Farm
    Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish16243470001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LOGVALE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    City Road
    EC1Y 2AB London
    30
    United Kingdom
    06 apr 2016
    City Road
    EC1Y 2AB London
    30
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6854101
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LOGVALE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 20 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title benefits and interest to all moneys from time to time due owing or incurred under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 20 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 20 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the initial chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All properties listed in the schedule of the deed including all buildings erections and fixtures and fittings and fixed plant equipment and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 20 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 lug 2006
    Consegnato il 28 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    6 blackwell gate darlington t/no DU164155. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 lug 2006
    Consegnato il 28 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as 35 and 37 and 39 to 49A (odd) parkgate road london t/no's TGL197525 and SGL456067 and f/h property known as 35 and 37 parkgate road and part of the adjoining dock t/no TGL197526. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 lug 2006
    Consegnato il 28 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    68 high street kings lynn norfolk t/no NK98650. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 lug 2006
    Consegnato il 28 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as 18 cowcross street and sabian house 27 and 28 cowcross street and land lying to the north of cowcross street t/no's NGL804567 and NGL776132 and l/h property known as part of zinc house 19 to 25 cowcross street t/no NGL786159. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 lug 2006
    Consegnato il 28 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of rents
    Creato il 06 nov 2001
    Consegnato il 09 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rents payable in respect of the f/h property k/a 18 cowcross street and sabin house 27/28 cowcross street EC1 and the l/h property k/a part zinc house, 19/26 cowcross street, london EC1.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of rents
    Creato il 06 nov 2001
    Consegnato il 09 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rents payable in respect of the f/h property k/a 39-49A parkgate road, london, SW11 and adjoining buildings.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 06 nov 2001
    Consegnato il 09 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of a floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 nov 2001
    Consegnato il 09 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 18 cowcross street and sabian house, 27/28 cowcross street and land at the rear of sabian house, 27/28 cowcross street, london, EC1, registered under part t/no NGL08816 and NGL776132 by way of assignment the goodwill and benefit of all licences. By way of floating charge all of its property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 nov 2001
    Consegnato il 09 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property k/a part zinc house, 19-26 cowcross street, london, EC1, t/no NGL786189 by way of assignment the goodwill and benefit of all licences. By way of floating charge all of its property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 nov 2001
    Consegnato il 09 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 39-49A parkgate road, london, SW11, t/nos 177518, SGL456067 and SGL379713 by way of assignment the goodwill and benefit of all licences. By way of floating charge all of its property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0