JARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED

JARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04277352
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova JARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAGICBROOK LIMITED28 ago 200128 ago 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di JARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per JARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 28 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 set 2011

    Stato del capitale al 05 set 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    legacy

    15 pagineMG01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    1 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per John Francis Jarvis il 05 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen James Hebborn il 05 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Duncan Jeremy Graham Beveridge il 05 nov 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    1 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    1 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    1 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    1 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 mar 2004

    1 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di JARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BEVERIDGE, Duncan Jeremy Graham
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    British65651540002
    HEBBORN, Stephen James
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish100382260002
    JARVIS, John Francis
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Castle House
    Desborough Road
    HP11 2PR High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish941890002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    THOMAS, David Owen
    7 Misbourne House
    Amersham Road
    HP8 4RY Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Misbourne House
    Amersham Road
    HP8 4RY Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    British642560002
    THOMASON, Richard Wooler
    Barley House
    6 Granary Close
    SN8 3UA East Grafton
    Wiltshire
    Amministratore
    Barley House
    6 Granary Close
    SN8 3UA East Grafton
    Wiltshire
    British84700430002

    JARVIS HOTELS KENSINGTON NOMINEE 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 15 mar 2010
    Consegnato il 25 mar 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 09 giu 2004
    Consegnato il 10 giu 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property ramada-jarvis kensington 31-34 queen's gate and 25 elvaston mews london t/nos BGL39558 and BGL39871.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 10 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of accession to the guarantee and fixed and floating security document dated 11 dated december 2003
    Creato il 16 mar 2004
    Consegnato il 19 mar 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal of Scotland PLC (As Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0