RED FUNNEL FERRIES LIMITED

RED FUNNEL FERRIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRED FUNNEL FERRIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04281782
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GREENSOURCE LIMITED05 set 200105 set 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Notifica di Falcon Acquisitions Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2018

    2 paginePSC02

    Cessazione di Red Funnel Group (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2018

    1 paginePSC07

    Notifica di Red Funnel Group (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2018

    2 paginePSC02

    Cessazione di Red Funnel Group Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2018

    1 paginePSC07

    Soddisfazione dell'onere 042817820005 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 31 gen 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Edward Arthur Wilson come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Francis Campbell come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles John Gore Hazelwood come amministratore in data 08 gen 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Jonathan Mark Moorhouse Green come amministratore in data 11 set 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Arthur Murray Carter come amministratore in data 11 set 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Mark Slawson come amministratore in data 11 set 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Wallace Inch come amministratore in data 12 set 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lee Richard Hudson come amministratore in data 12 set 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Shirley Ann Anderson come amministratore in data 13 set 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 042817820004 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 042817820005, creata il 20 lug 2017

    17 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GEORGE, Kevin Alan
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish186130710001
    WINTER, Paul Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish132752850001
    HUME, Kate
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    Segretario
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    British78063700002
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Segretario
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    British8125620001
    SHEARD, John Paul
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    Segretario
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    British61554710001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDERSON, Shirley Ann
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish254667910001
    BLAND, Christopher Donald Jack
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    United KingdomBritish8125610001
    BRADBURY, Kenton Edward
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish147513860001
    CAMPBELL, Michael Francis
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    CanadaCanadian235365510001
    CARTER, Arthur Murray
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish127391460001
    COOPER, James Nigel Shelley
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish265561970001
    DELLACHA, Maria Georgina
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish174489750001
    DOCHERTY, Thomas James
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritish83269560002
    DOMINY, Jacqueline
    Woodlands 46 Telegraph Road
    West End
    SO30 3EX Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Woodlands 46 Telegraph Road
    West End
    SO30 3EX Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish206004200001
    EDWARDS, Keith David William
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish114681720002
    FULFORD, James Simon Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish137465940001
    GLASS, Olive Helen
    55 Ashdale Park
    RG40 3QS Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    55 Ashdale Park
    RG40 3QS Wokingham
    Berkshire
    British38249750003
    GORDON, Gavin James
    Flat 8 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7ER London
    Amministratore
    Flat 8 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7ER London
    British90600880001
    GREEN, Jonathan Mark Moorhouse
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish127407610001
    HAZELWOOD, Charles John Gore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish111535480002
    HELMORE, Max David Charles
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish174349030001
    HETHERINGTON, Colin Crawford
    Woodpeckers
    64 Baring Road
    PO31 8DJ Cowes
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Woodpeckers
    64 Baring Road
    PO31 8DJ Cowes
    Isle Of Wight
    British103607280004
    HUDSON, Lee Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish156861680001
    INCH, John Wallace
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish222917320001
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    British8125620001
    NELSON, Stephen Keith James
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish91708030001
    RAYNER, William John
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish99969530001
    SCHUMACHER, Bernd
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandGerman169583030001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish107002130001
    SLAWSON, James Mark
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish191539160001
    WHYTE, Alistair Morrison
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish8125600001
    WILSON, Edward Arthur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Amministratore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish214718430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Red Funnel Group (Holdings) Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    31 gen 2018
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione05115188
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Falcon Acquisitions Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    31 gen 2018
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione06238324
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Red Funnel Group Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    06 apr 2016
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneUk Company Register
    Numero di registrazione03968658
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RED FUNNEL FERRIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 lug 2017
    Consegnato il 27 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All land (except for restricted land) as listed in schedule 1 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery at any time thereon, intellectual property (except for any restricted ip), and the specified intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbc Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 27 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 lug 2016
    Consegnato il 12 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 12 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 ott 2007
    Consegnato il 01 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Red funnel deed of charge
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 02 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings being k/a the red funnel ferry terminal car parks and car marshalling areas east cowes isle of wight t/nos IW49024, IW49023, IW49041, IW42695, IW29058 all f/h land and buildings at fountain quay west cowes t/no IW49025 f/h land and buldings at 10,12,14 and 16 bugle street southampton t/no HP596087 (for full details of all property charged see form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York (For Itself and on Behalf of the Other Red Funnel Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 02 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ott 2001
    Consegnato il 26 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present or future obligations of the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 26 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0