LEICESTERSHIRE BUSINESS VOICE
Panoramica
| Nome della società | LEICESTERSHIRE BUSINESS VOICE |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
| Numero di società | 04287002 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LEICESTERSHIRE BUSINESS VOICE?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova LEICESTERSHIRE BUSINESS VOICE?
| Indirizzo della sede legale | 3 Friars Mill 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester Leicestershire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di LEICESTERSHIRE BUSINESS VOICE?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LEICESTERSHIRE BUSINESS VOICE?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 15 ott 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 29 ott 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 15 ott 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per LEICESTERSHIRE BUSINESS VOICE?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2025 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mrs Leanne Jayne Bonner-Cooke come amministratore in data 03 set 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Sean Michael Jarvis come amministratore in data 07 mag 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Dillan Shikotra come amministratore in data 02 apr 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2024 | 6 pagine | AA | ||
Nomina di Mrs Susan Mary Tilley come amministratore in data 05 mar 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Sean Michael Jarvis come amministratore in data 17 mag 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2023 | 6 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Mark Paul Robinson come amministratore in data 14 dic 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Jenny Rebecca Fensome come amministratore in data 01 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022 | 6 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Consort House 15 De Montfort Place Leicester LE1 7GZ England a 3 Friars Mill 100 Bath Lane Leicester Leicestershire LE3 5BJ in data 03 gen 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Dr Jenny Rebecca Fensome come amministratore in data 27 set 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Graham Edgar Watts come amministratore in data 15 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Dafydd Llywelyn Prichard come amministratore in data 26 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mrs Sandra Wiggins come amministratore in data 11 apr 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Iain Andrew Mckenzie come amministratore in data 20 apr 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di LEICESTERSHIRE BUSINESS VOICE?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNER-COOKE, Leanne Jayne | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | England | British | 229363720001 | |||||
| BULSARA, Mukesh Ratilal | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | England | British | 222061560002 | |||||
| COWLEY, Jane | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | United Kingdom | British | 150573850001 | |||||
| MCGHEE, Neil Kenneth Ormrod | Amministratore | De Montfort Place LE1 7GZ Leicester 15 England | United Kingdom | British | 112915690002 | |||||
| MCKENZIE, Iain Andrew | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | England | British | 162090430001 | |||||
| MERCHANT, Roger Leonard | Amministratore | Bottom Green Upper Broughton LE14 3BA Melton Mowbray Ivy House England | England | British | 141300420002 | |||||
| POINTON, Robin Pratt | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | England | British | 112467750001 | |||||
| ROBINSON, Mark Paul | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | England | British | 317180410001 | |||||
| SHIKOTRA, Dillan | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | United Kingdom | British | 334328060001 | |||||
| TILLEY, Susan Mary | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | England | British | 97560360001 | |||||
| TREVEDI, Anjuu | Amministratore | University Road LE1 1RF Leicester Fielding Johnson Building England | England | British | 257067330001 | |||||
| WIGGINS, Sandra | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | England | British | 294844550001 | |||||
| LAMIN, Ann Margaret | Segretario | Castle Close Uppingham LE15 9PN Oakham 4 Rutland England | British | 80370940001 | ||||||
| WILLIAMS, David | Segretario | Manor House Stretton Hall LE2 4QX Oadby | British | 4301510005 | ||||||
| ALLSOP, Richard Anthony | Amministratore | 46 Knighton Church Road LE2 3JH Leicester | England | British | 40955110002 | |||||
| ANADKAT, Aatin | Amministratore | c/o Gateley Uk Lower Brown Street LE1 5NL Leicester Knightsbridge House England | United Kingdom | British | 147419210001 | |||||
| ASCH, David Conrad, Professor | Amministratore | 30 Erringtons Close LE2 4RP Oadby Leicestershire | United Kingdom | British | 86150610002 | |||||
| ASTILL, John Paul | Amministratore | c/o Gateley Uk Lower Brown Street LE1 5NL Leicester Knightsbridge House England | England | British | 125294330002 | |||||
| ATKINSON, Paul Edward | Amministratore | The Old Glebe House 35 Little Church Lane Sileby LE12 7NE Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 14186560003 | |||||
| BACON, Andrew David | Amministratore | c/o Gateley Uk Lower Brown Street LE1 5NL Leicester Knightsbridge House England | England | British | 188271400001 | |||||
| BLAND, Philip Anthony | Amministratore | Beeby Manor Beeby LE7 3BL Leicester Leicestershire | England | British | 19696590001 | |||||
| BORLEY, Ian James | Amministratore | 1 Waterloo Way LE1 6LP Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 124536410001 | |||||
| BOTTERILL, Roy | Amministratore | Billinghay Lodge 54 Cossington Road LE12 7RS Sileby Leicestershire | United Kingdom | British | 77613990002 | |||||
| BOWIE, James | Amministratore | The Meadows Kilby Road Kilby Road LE8 8BQ Fleckney Leicestershire | British | 16012950001 | ||||||
| BRUCCIANI, Richard Louis | Amministratore | The Beeches Elmfield Avenue LE2 1RD Leicester Leicestershire | England | British | 7104900002 | |||||
| BRUNTON, David | Amministratore | 522 Bradgate Road Newtown Linford LE6 0HB Leicester | England | British | 63101700001 | |||||
| BURTON, Gary | Amministratore | 22 Hardwick Close LE15 6FF Oakham Rutland | British | 78624500002 | ||||||
| CENEY, Adrian Charles | Amministratore | Charles Street LE1 1HA Leicester Halford House England | England | British | 234741760001 | |||||
| CLARK, Rosemary Jean | Amministratore | c/o Gateley Uk Lower Brown Street LE1 5NL Leicester Knightsbridge House | United Kingdom | British | 178137990002 | |||||
| COYNE, John | Amministratore | Victoria House 30 Lime Grove Avenue Beeston NG9 4AR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 28330280001 | |||||
| EVANS, Margaret, Professor | Amministratore | Yew Tree House NG25 0QP Halloughton Nottinghamshire | British | 95056120001 | ||||||
| FENSOME, Jenny Rebecca, Dr | Amministratore | 100 Bath Lane LE3 5BJ Leicester 3 Friars Mill Leicestershire England | United Kingdom | British | 300783000001 | |||||
| FOOT, Stephen John | Amministratore | c/o Gateley Uk Lower Brown Street LE1 5NL Leicester Knightsbridge House England | United Kingdom | British | 162955870001 | |||||
| HAMILTON, Alastair John | Amministratore | c/o Gateley Uk Lower Brown Street LE1 5NL Leicester Knightsbridge House England | United Kingdom | British | 206673230001 | |||||
| HULL, Francis William | Amministratore | Westdale 7 The Bank Arnesby LE8 5WE Leicester | British | 14448270004 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per LEICESTERSHIRE BUSINESS VOICE?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 15 ott 2016 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0