KANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED

KANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04289112
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova KANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Nuffield House
    41-46 Piccadilly
    W1J 0DS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRECIS (2104) LIMITED18 set 200118 set 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di KANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per KANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mag 2012

    Stato del capitale al 01 mag 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2010 al 30 giu 2011

    1 pagineAA01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Michael Creak il 02 mag 2011

    2 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Tyler come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    7 pagineAA

    legacy

    19 pagine395

    Risoluzioni

    Resolutions
    14 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di KANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CREAK, Michael
    New Park Road
    GU6 7HL Cranleigh
    Whitehaven
    United Kingdom
    Segretario
    New Park Road
    GU6 7HL Cranleigh
    Whitehaven
    United Kingdom
    Other118743590001
    HILL, Amanda Jane
    Quinton Street
    Earlsfield
    SW18 3QS London
    60a
    Amministratore
    Quinton Street
    Earlsfield
    SW18 3QS London
    60a
    United KingdomBritishProperty Investment105932470001
    MAHENDRA, Myron Murugendra
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    Segretario
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    British62660140005
    MCGANN, Martin Francis
    34 Circus Street
    Greenwich
    SE10 8SN London
    Segretario
    34 Circus Street
    Greenwich
    SE10 8SN London
    BritishChartered Accountant109383240002
    O'NEILL, Brian
    7 Woodbrook
    Rochestown Road
    IRISH Cork
    Ireland
    Segretario
    7 Woodbrook
    Rochestown Road
    IRISH Cork
    Ireland
    Irish87734240001
    PHOENIX, Christopher John
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    BritishDirector16220320001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    Segretario nominato
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    900019420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TEMPLE SECRETARIAL LIMITED
    16 Old Bailey
    EC4M 7EG London
    Segretario
    16 Old Bailey
    EC4M 7EG London
    73539310001
    ARNOLD, Jeremy Patrick
    1 Pentire Close
    Shores Road
    GU21 4PZ Woking
    Surrey
    Amministratore
    1 Pentire Close
    Shores Road
    GU21 4PZ Woking
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor101568980001
    BHATIA, Kamal
    5 Highfields Grove
    Fitzroy Park
    N6 6HN London
    Amministratore
    5 Highfields Grove
    Fitzroy Park
    N6 6HN London
    EnglandIndianProperty Consultant82610530001
    DALE, James Hall
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Amministratore
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishChartered Accountant84675480001
    JOHNSON, Andrew William
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director68089410003
    KELLEHER, Michael
    Bridgehill, Anglish
    Balleneadig
    IRISH Coachford
    Cork
    Ireland
    Amministratore
    Bridgehill, Anglish
    Balleneadig
    IRISH Coachford
    Cork
    Ireland
    IrelandIrishDirector99150420001
    LEE, Peter John Gorringe
    South Park Farm
    Lower South Park
    RH9 8LF South Godstone
    Surrey
    Amministratore
    South Park Farm
    Lower South Park
    RH9 8LF South Godstone
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor83600080001
    LEWIS, Simon Nicholas Hewitt
    Bickley Court
    36 Chiselhurst Road
    BR1 2NW Bickley
    Kent
    Amministratore
    Bickley Court
    36 Chiselhurst Road
    BR1 2NW Bickley
    Kent
    United KingdomBritishDirector60744980001
    MCGANN, Martin Francis
    34 Circus Street
    Greenwich
    SE10 8SN London
    Amministratore
    34 Circus Street
    Greenwich
    SE10 8SN London
    EnglandBritishChartered Accountant109383240002
    MELHUISH, Richard Marcus
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor83530000001
    NESBITT, John Oliver
    Stoke Court
    Greete
    SY8 3BX Ludlow
    Shropshire
    Amministratore
    Stoke Court
    Greete
    SY8 3BX Ludlow
    Shropshire
    EnglandBritishDirector99542990002
    O NEIL, Brian
    7 Woodbrook
    IRISH Rochester Town
    Cork
    Ireland
    Amministratore
    7 Woodbrook
    IRISH Rochester Town
    Cork
    Ireland
    IrishCompany Director116920110001
    O'FLYNN, Michael Joseph
    Melbourne House
    Model Farm Road
    IRISH Cork
    Eire
    Amministratore
    Melbourne House
    Model Farm Road
    IRISH Cork
    Eire
    IrishDirector19022840001
    PHOENIX, Christopher John
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Mount Pleasant Farm Station Road
    Sturton Le Steeple
    DN22 9HS Retford
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector16220320001
    TYLER, Michael Peters
    Haydon Park Road
    SW19 8JH London
    99
    Amministratore
    Haydon Park Road
    SW19 8JH London
    99
    BritishChartered Surveyor108051840001
    WILLIAMS, John
    13 Doran Drive
    RH1 6AX Redhill
    Surrey
    Amministratore
    13 Doran Drive
    RH1 6AX Redhill
    Surrey
    BritishChartered Surveyor36333640001
    PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Amministratore delegato nominato
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    900019410001

    KANDAHAR (NOTTINGHAM) NOMINEE NO.1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 lug 2007
    Consegnato il 24 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 01 dic 2004
    Consegnato il 11 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 dic 2004
    Consegnato il 11 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (I) f/hold land being newtown house,maid arion way,nottingham NG1 6GG; NT292359; (ii) l/hold land beng newown house and land and buildings adjoining maid marion way and land and wall and buttresses thereof; NT203598; (iii) f/hold land being newland house and albany hotel,maid marion way,city of nottingham;NT203599; see form 395 or details of other properties. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 lug 2004
    Consegnato il 26 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any chargor to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property forming part of maid marion way nottingham t/no NT292359, f/h property forming part of maid marion way nottingham t/no NT203599, l/h property forming part of maid marion way nottingham t/no NT203598. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 26 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 lug 2002
    Consegnato il 18 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower each other obligor and the company to the agent and/or the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H and l/h property k/a maid marion way nottingham (newton house, newland house forte post hotel and ncp car park) t/no NT263599, NT292359, NT203598, NT18366 and NT18348. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 18 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party legal mortgage
    Creato il 03 lug 2002
    Consegnato il 09 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due by the chargors to the chargee and the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (I) f/hold property known as 75 taff street,pontypridd; WA276169; (ii) f/hold property known as 75A and 76 taff st,pontypridd; WA287000; (iii) f/hold property known as 99-101 peascod st,windsor; t/nos BK91793 and BK340151 plus other properties listed; all plant,machinery,vehicles,computers,office and other equipment thereon and all rights and claims and any policies of insurance; floating charge over all undertaking; see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Crp General Partner Limited,the Security Trustee
    Transazioni
    • 09 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between precis (2104) limited and precis (2105) limited (together the "chargor") and anglo irish bank corporation PLC (the "bank")
    Creato il 01 nov 2001
    Consegnato il 10 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities due from the borrower or general partner (crp general partner limited) to the chargee and/or the beneficiaries (as defined) under the finance documents (as defined) and all other liabilities due from the chargor to the agent under the debenture
    Brevi particolari
    All freehold or leasehold property with all fittings,plant,machinery,equipment,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property; any investment,goodwill of business and uncalled capital; all cash at bank and any intellectual property and any debts or guarantee or security; see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0