LIQUICO APH LIMITED

LIQUICO APH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLIQUICO APH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04290300
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LIQUICO APH LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova LIQUICO APH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    K House Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LIQUICO APH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACCESSPLUS HOLDINGS LIMITED17 ott 200817 ott 2008
    ACCESSPLUS HOLDINGS PLC17 ott 200817 ott 2008
    TRIPLEARC PLC19 set 200119 set 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di LIQUICO APH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per LIQUICO APH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 dic 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name02 dic 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 02 dic 2016

    RES15

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 nov 2016

    • Capitale: GBP 0.05
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2016 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 mag 2016

    • Capitale: GBP 34,285,977.25
    5 pagineSH01

    Indirizzo della sede legale modificato da St Crispins Duke Street Norwich Norfolk NR3 1PD a K House Sheffield Airport Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU in data 12 mag 2016

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 042903000014 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 042903000012 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 042903000013 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 042903000011 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 042903000009 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 042903000010 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Robert Rolph Baldrey come amministratore in data 13 apr 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Haworth come amministratore in data 13 apr 2016

    2 pagineAP01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato K House Sheffield Airport Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a K House Sheffield Airport Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU

    1 pagineAD02

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di LIQUICO APH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MENDELSOHN, Lorna
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Segretario
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    194463540001
    GALE, Andrew Peter
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Amministratore
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    EnglandBritish155681500001
    HAWORTH, Stephen
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Amministratore
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    EnglandBritish155690570001
    FOWEN, Yvonne Pauline
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Segretario
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    British26389070002
    GREENAN, Shane Padraig
    7 Normanhurst Mansions
    Vera Road
    SW6 6QN London
    Segretario
    7 Normanhurst Mansions
    Vera Road
    SW6 6QN London
    Irish78503500001
    HOLMES, Julian
    28 Tempest Drive
    NP16 5AY Chepstow
    Gwent
    Segretario
    28 Tempest Drive
    NP16 5AY Chepstow
    Gwent
    British110668840001
    RODWELL, Debbie
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Segretario
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    British103054490001
    SMITH, Angela Clare
    35 Lime Road
    Southville
    BS3 1LS Bristol
    Avon
    Segretario
    35 Lime Road
    Southville
    BS3 1LS Bristol
    Avon
    British100635720001
    WONG, Jun Tsiong
    59 Gilbey House
    Jamestown Road
    NW1 7BY London
    Segretario
    59 Gilbey House
    Jamestown Road
    NW1 7BY London
    British72387070001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINS, Richard Charles
    Crescent House
    The Quillot, Burwood Park
    KT12 5BY Walton-On-Thames
    Surrey
    Amministratore
    Crescent House
    The Quillot, Burwood Park
    KT12 5BY Walton-On-Thames
    Surrey
    EnglandBritish104670700001
    BALDREY, Robert Rolph
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish78328360005
    BALDREY, Robert Rolph
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish78328360005
    BRETTELL, Timothy Geoffrey
    Abbots Leigh House
    Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    Amministratore
    Abbots Leigh House
    Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    British16193990002
    CAWLEY, Hugh Charles Laurence
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    United KingdomBritish41820960003
    CROMACK, Jason Charles Edward
    Fairmead Iford Fields
    Lower Westwood
    BA15 2BQ Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    Fairmead Iford Fields
    Lower Westwood
    BA15 2BQ Bradford On Avon
    Wiltshire
    EnglandBritish148492510001
    CUNNINGHAM, Mark Andrew
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish130923460003
    EMERSON, Daniel Paul Ambrose
    22 Lower Kings Road
    KT2 5HR Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    22 Lower Kings Road
    KT2 5HR Kingston Upon Thames
    Surrey
    British86437650001
    GALE, Andrew Peter
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish155681500001
    GREENAN, Shane Padraig
    128 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    Amministratore
    128 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    Irish78503500002
    HAIGH, Nicholas Jonathan
    36 Ray Park Avenue
    SL6 8DY Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    36 Ray Park Avenue
    SL6 8DY Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish141774490001
    HODGSON, Richard
    13 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    Amministratore
    13 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    United KingdomBritish96788660005
    HOUSTON, Peter Richard Vivian
    Fair Dawn Packhorse Lane
    Southstoke
    BA2 7DL Bath
    Somerset
    Amministratore
    Fair Dawn Packhorse Lane
    Southstoke
    BA2 7DL Bath
    Somerset
    United KingdomBritish113014870001
    MCKEEVER, Stephen Anthony
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish127513700001
    MOATE, Simon Richard
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish126182400002
    OBRIEN, Conor
    40b Lower Belgrave Street
    SW1W 0LN London
    Amministratore
    40b Lower Belgrave Street
    SW1W 0LN London
    Irish78295600003
    PASSMORE, Colin
    Little Willinford Willingford Lane
    Burwash Weald
    TN19 7HR East Sussex
    Amministratore
    Little Willinford Willingford Lane
    Burwash Weald
    TN19 7HR East Sussex
    British60831650001
    POPLE, Christopher John
    4 College Fields
    BS8 3HP Bristol
    Amministratore
    4 College Fields
    BS8 3HP Bristol
    United KingdomBritish10061330005
    RYDING, Peter John
    Cuddy Thorne
    Cow Pool Berrick Salome
    OX10 6JJ Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Cuddy Thorne
    Cow Pool Berrick Salome
    OX10 6JJ Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish95144000001
    WONG, David
    37-06-3 Sri Penaga
    Jalan Medang Serai Bukit Bandar Raya
    FOREIGN Kuala Lumpur
    59100
    Malaysia
    Amministratore
    37-06-3 Sri Penaga
    Jalan Medang Serai Bukit Bandar Raya
    FOREIGN Kuala Lumpur
    59100
    Malaysia
    MalaysiaMalaysian95576350001
    WONG, Jun Tsiong
    1a Canning Place
    W8 5AD London
    Amministratore
    1a Canning Place
    W8 5AD London
    British72387070003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Amministratore delegato nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LIQUICO APH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Endless Iii General Partner Llp
    Festival Square
    Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    06 apr 2016
    Festival Square
    Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Partnership
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScottish
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc303405
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Endless Llp
    Whitehall Quay
    LS1 4BF Leeds
    3
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Whitehall Quay
    LS1 4BF Leeds
    3
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Partnership
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazioneOc316569
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Endless Ii Gp Llp
    Festival Square
    Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    06 apr 2016
    Festival Square
    Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Partnership
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScottish
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc335665
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Office2office Limited
    Sheffield Airport Business Park, Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    06 apr 2016
    Sheffield Airport Business Park, Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione04083206
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    LIQUICO APH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H property k/a 16A crawfordsburn road newtownards county down.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 30 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 30 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 29 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The property known as 8 trench road, hydepark, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN28700L county antrim and held under indenture of lease dated the 15TH day of march 1991 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate adjacent to 8 trench road, hydepark industrial estate, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN30433L county antrim and held under indenture of lease dated the 26TH day of august 1993 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate at 16A crawfordsburn road, newtownards, county down comprised in and demised by indenture of lease dated the 12TH day of august 1994 and made between northern engineering enterprises limited (1) secretary of state for the environment (2) for the term of twenty-five (25) years from the 20TH day of june 1994 subject as therein (as registered in the registry of deeds on the 6TH day of september 1994, serial number 1994-120-033).
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 29 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold land known as "software stationery specialists", wheatfield way, hinckley, LE10 1YG. Title number LT244150.. The leasehold land known as lexicon house, midleton road, guildford, GU2 8XP. Title number SY820787.. The leasehold land known as dorcan 300, murdoch road, dorcan, swindon SN3 5HY. Title number WT307925.. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 12 nov 2008
    Consegnato il 15 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 ott 2003
    Consegnato il 29 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LIQUICO APH LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 dic 2016Inizio della liquidazione
    25 apr 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0