BETT (CALVER ROAD) LIMITED

BETT (CALVER ROAD) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBETT (CALVER ROAD) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04293393
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ashley House
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    READCO 309 LIMITED25 set 200125 set 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 16 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 set 2010

    Stato del capitale al 30 set 2010

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Michael Milligan come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Nomina di Paul Curran come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Gaffney come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Neil Fitzsimmons come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 29 gen 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Lavelle come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robin Johnson come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Joanne Elizabeth Massey come segretario

    2 pagineAP03

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del segretario cambiati per Robin Simon Johnson il 24 nov 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 13 nov 2009

    2 pagineCH01

    Nomina di Dominic Joseph Lavelle come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2007

    14 pagineAAMD

    Risoluzioni

    Resolutions
    33 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Director's authorisation 01/09/2009
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808340001
    CURRAN, Paul
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish110978610002
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    MILLIGAN, Michael
    Lauriston Place
    EH3 9EN Edinburgh
    15
    United Kingdom
    Amministratore
    Lauriston Place
    EH3 9EN Edinburgh
    15
    United Kingdom
    ScotlandBritish153845120001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JACKSON, Guy Collingwood
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    British54131050002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Segretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Amministratore
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritish91412650001
    BOND, Julian
    Broomfield House
    32 Hullen Edge Road
    HX5 0QY Elland
    Yorkshire
    Amministratore
    Broomfield House
    32 Hullen Edge Road
    HX5 0QY Elland
    Yorkshire
    United KingdomBritish44995320003
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    JACKSON, Guy Collingwood
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    British54131050002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    ROBINSON, David
    118 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    118 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Lothian
    ScotlandUnited Kingdom50541770001
    TOWNSEND, Ian Trye
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    Amministratore
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    United KingdomBritish320150001

    BETT (CALVER ROAD) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 09 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed legal charge
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 03 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First fixed charge over the interest bearing account and any amount which may exist in the account from time to time.
    Persone aventi diritto
    • I.M. Properties Finance Limited
    Transazioni
    • 03 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2003
    Consegnato il 24 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 20 mag 2003
    Consegnato il 28 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land to the south of calver road,winwick quay, warrington t/n CH478322. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0