BADMINTON HEALTHCARE LTD
Panoramica
Nome della società | BADMINTON HEALTHCARE LTD |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04293809 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BADMINTON HEALTHCARE LTD?
- (8514) /
Dove si trova BADMINTON HEALTHCARE LTD?
Indirizzo della sede legale | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BADMINTON HEALTHCARE LTD?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per BADMINTON HEALTHCARE LTD?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Angela Culhane come amministratore in data 25 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2011 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Jonathan David Calow come segretario in data 08 dic 2011 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Care Uk Services Limited come segretario in data 08 dic 2011 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 ago 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Paul John Watson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 ago 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Paul Justin Humphreys il 01 ago 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Care Uk Services Limited il 01 ago 2010 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael Robert Parish il 10 ago 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 28 pagine | MG01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2009 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Deborah Jane Marriott-Boam come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey Benn come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Roy Hastings come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Douglas Umbers come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Angela Hector Culhane come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Chi sono gli amministratori di BADMINTON HEALTHCARE LTD?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALOW, Jonathan David | Segretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | 165428740001 | |||||||||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | Director | 33223550003 | ||||||||
MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | Company Director | 151689670001 | ||||||||
PARISH, Michael Robert | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | England | British | Director | 78828750003 | ||||||||
WATSON, Paul John | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | Accountant | 82460360003 | ||||||||
HELLEY, Theresa | Segretario | The Bungalow Oat Hedges Farm BS27 3RU Cheddar Somerset | British | Manager | 78190350001 | |||||||||
HODGKINS, Leigh | Segretario | 8 Evergreen Charter House BS40 7XS Blagdon Somerset | British | It Consultant | 117712190001 | |||||||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Segretario | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | Director | 33223550003 | |||||||||
STADDEN, Hilary Anne | Segretario | 16 Greenleaze Close Downend BS16 6LW Bristol | British | 80075380001 | ||||||||||
CARE UK SERVICES LIMITED | Segretario | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125332040002 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
BENN, Geoffrey Richard | Amministratore | 15 Mimosa Close CM1 6NW Chelmsford Essex | England | British | Company Director | 73786580001 | ||||||||
BOOKER, Roger Ian | Amministratore | Fairview 17a Queens Road WA15 9HF Hale Cheshire | United Kingdom | British | Director | 14044530003 | ||||||||
CULHANE, Angela | Amministratore | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | England | British | Company Director | 68602910001 | ||||||||
HASTINGS, Roy | Amministratore | Wallis Road RG21 3DN Basingstoke 20 Hampshire | England | British | Company Director | 130098430001 | ||||||||
HODGKINS, Maureen | Amministratore | Evergreen Charterhouse On Mendip BS40 7SX Blagdon Somerset | British | Nurse | 78191690005 | |||||||||
HODGKINS, Philip Steven | Amministratore | Evergreen Charterhouse On Mendip BS40 7SX Blagdon Somerset | British | Director | 78191730003 | |||||||||
UMBERS, Douglas | Amministratore | Tyrrel House Tyrrel Road Chandlers Ford SO53 1GG Eastleigh Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 90541690001 | ||||||||
VOCKINS, Anthony Frederick | Amministratore | 4 Main Street Croxton Kerrial NG32 1QF Grantham The Old Post Office Lincolnshire | England | British | Company Director | 130512090002 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
BADMINTON HEALTHCARE LTD ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 21 lug 2010 Consegnato il 26 lug 2010 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 10 dic 2009 Consegnato il 23 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 mar 2009 Consegnato il 13 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 mar 2004 Consegnato il 02 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0