ALEXANDRA MILLS LIMITED

ALEXANDRA MILLS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALEXANDRA MILLS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04295356
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALEXANDRA MILLS LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova ALEXANDRA MILLS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALEXANDRA MILLS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALEXANDER MILLS LIMITED27 set 200127 set 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALEXANDRA MILLS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per ALEXANDRA MILLS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    17 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 mag 2017

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 mag 2015

    9 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 mag 2016

    10 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Paylings 7 the Office Camous Red Hall Court Paragon Wakefield West Yorkshire WF1 2UY a 29 Park Square West Leeds LS1 2PQ in data 24 mar 2015

    3 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 ott 2014

    Stato del capitale al 30 ott 2014

    • Capitale: GBP 664,063
    SH01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2013 al 31 mar 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 ott 2013

    Stato del capitale al 02 ott 2013

    • Capitale: GBP 664,063
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    11 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    11 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 36 Bond Street Wakefield West Yorkshire WF1 2QP* in data 08 set 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2009

    10 pagineAA

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 18 feb 2010

    • Capitale: GBP 664,063
    4 pagineSH06

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Risoluzioni

    Resolutions
    19 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    Varie

    Directors statement and aud report re section 714 ca 2006 ( repurchase of shares)
    3 pagineMISC

    legacy

    10 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di ALEXANDRA MILLS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURNS, Ann
    Walton Grange Cottage
    201 Shay Lane Walton
    WF2 6NW Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    Walton Grange Cottage
    201 Shay Lane Walton
    WF2 6NW Wakefield
    West Yorkshire
    British4381230003
    ARMSTRONG, Keiron Barry
    Knightcross
    Newstead Abbey Park Ravenshead
    NG15 8GE Nottingham
    Amministratore
    Knightcross
    Newstead Abbey Park Ravenshead
    NG15 8GE Nottingham
    EnglandBritish32536070003
    ARMSTRONG, Terry Owen
    Drummond Lodge 72 Highfield Road
    Nuthall
    NG16 1BP Nottingham
    Amministratore
    Drummond Lodge 72 Highfield Road
    Nuthall
    NG16 1BP Nottingham
    United KingdomBritish62815220002
    BRAIDE, William Gordon
    Sandal Lodge
    Walton Lane Sandal
    WF2 6NG Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sandal Lodge
    Walton Lane Sandal
    WF2 6NG Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish78542290001
    HARRISON, David Neil
    Brackendale Cottage
    71 Church Street
    WF5 9DT Ossett
    West Yorkshire
    Amministratore
    Brackendale Cottage
    71 Church Street
    WF5 9DT Ossett
    West Yorkshire
    EnglandBritish95843170001
    MARZANO, Giuliano
    Burton House
    Newcastle Circus The Park
    NG7 1BJ Nottingham
    Amministratore
    Burton House
    Newcastle Circus The Park
    NG7 1BJ Nottingham
    United KingdomBritish10079150003
    RUDDIMAN, David Anthony Peter
    Fixby Lodge
    Fixby Park
    HD2 2ER Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fixby Lodge
    Fixby Park
    HD2 2ER Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish15132270002
    HARRISON, David Neil
    Brackendale Cottage
    71 Church Street
    WF5 9DT Ossett
    West Yorkshire
    Segretario
    Brackendale Cottage
    71 Church Street
    WF5 9DT Ossett
    West Yorkshire
    British95843170001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    51066720001
    BATTYE, Stephen Paul
    Gothic House
    Park Road
    WF13 4LR Dewsbury
    West Yorkshire
    Amministratore
    Gothic House
    Park Road
    WF13 4LR Dewsbury
    West Yorkshire
    United KingdomBritish9282480001
    FOX, Brian Nigel
    Apartment 27 Boothroyds Apartments
    Halifax Road
    WF13 2AS Dewsbury
    Amministratore
    Apartment 27 Boothroyds Apartments
    Halifax Road
    WF13 2AS Dewsbury
    British80084030001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    Amministratore
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    51066670001

    ALEXANDRA MILLS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 28 set 2004
    Consegnato il 05 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 05 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 28 set 2004
    Consegnato il 05 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Alexandra mills alexandra road batley t/n WYK54930,. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 05 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 02 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being alexandra mills alexandra road batley west yorkshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ALEXANDRA MILLS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 mag 2014Inizio della liquidazione
    12 dic 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Frederick Wilson
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    Praticante
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0